24
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Postes Canada Accord sur la vente de produits n o 40065485 Canada Post Product Sales Agreement # 40065485 Vol. 161 Wednesday, January 22, 2003 / Le mercredi 22 janvier 2003 65 ISSN 0703-8623 Notice to Readers Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the editor no later than noon, at least 9 days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the editor. PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2003-7, I declare that the Opticians Act, chapter 58, of the Acts of New Brunswick, 2002, comes into force January 16, 2003. This Proclamation is given under my hand and the Great Seal of the Province at Fredericton on January 9, 2003. Bradley Green, Q.C. Marilyn Trenholme Counsell Attorney General Lieutenant-Governor Proclamations Avis aux lecteurs Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à l’éditrice, à midi, au moins 9 jours avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec l’éditrice. PROCLAMATION Conformément au décret en conseil 2003-7, je déclare le 16 janvier 2003 date d’entrée en vigueur de la Loi sur les opticiens, chapitre 58 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002. La présente proclamation est faite sous mon seing et sous le grand sceau de la Province, à Fredericton, le 9 janvier 2003. Le procureur général, La lieutenante-gouverneure, Bradley Green, c.r. Marilyn Trenholme Counsell Proclamations

The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Postes CanadaAccord sur la vente de produits

no 40065485

Canada PostProduct Sales Agreement

# 40065485

Vol. 161 Wednesday, January 22, 2003 / Le mercredi 22 janvier 2003 65

ISSN 0703-8623

Notice to Readers

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe editor no later than noon, at least 9 days prior toWednesday’s publication. However, when there is apublic holiday, please contact the editor.

PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2003-7, I declare that the Opticians Act,chapter 58, of the Acts of New Brunswick, 2002, comes into forceJanuary 16, 2003.

This Proclamation is given under myhand and the Great Seal of the Provinceat Fredericton on January 9, 2003.

Bradley Green, Q.C. Marilyn Trenholme CounsellAttorney General Lieutenant-Governor

Proclamations

Avis aux lecteurs

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à l’éditrice, àmidi, au moins 9 jours avant le mercredi de publication.En cas de jour férié, veuillez communiquer avecl’éditrice.

PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2003-7, je déclare le 16 janvier2003 date d’entrée en vigueur de la Loi sur les opticiens, chapitre 58des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002.

La présente proclamation est faite sousmon seing et sous le grand sceau de laProvince, à Fredericton, le 9 janvier2003.

Le procureur général, La lieutenante-gouverneure,Bradley Green, c.r. Marilyn Trenholme Counsell

Proclamations

Page 2: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003

DECEMBER 19, 20022002-453

Under paragraph 6(1)(b) of the New Brunswick Arts Board Act, theLieutenant-Governor in Council appoints the following persons asmembers of the New Brunswick Arts Board:

(a) Paul Daigle, Fredericton, New Brunswick, for a term of threeyears; and(b) Ludmila Knezkova-Hussey, Bathurst, New Brunswick, for aterm of two years.

Marilyn Trenholme Counsell, Lieutenant-Governor

_________________

DECEMBER 19, 20022002-454

1. Under paragraph 2(2)(a) of the Research and Productivity CouncilAct, the Lieutenant-Governor in Council designates the AtlanticCanada Opportunities Agency as the agency of the Government ofCanada which can nominate a person for appointment as a member ofthe Council under the said paragraph.2. Under paragraphs 2(2)(b) and 2(2)(d) of the Research and Produc-tivity Council Act, the Lieutenant-Governor in Council designates theMinister of Business New Brunswick to be the member of ExecutiveCouncil who will have the authority to nominate persons for appoint-ment as members of the Council under the said paragraphs.3. Under subsection 2(1) and paragraph 2(2)(a) of the Research andProductivity Council Act, the Lieutenant-Governor in Council appointsBrian Dick as a person nominated by the designated agency of theGovernment of Canada, for a term of three years.

4. Under subsection 2(1) and paragraph 2(2)(b) of the Research andProductivity Council Act, the Lieutenant-Governor in Council appointsJacques Dubé, Deputy Minister, Business New Brunswick, as a mem-ber of the Council nominated by the member of the Executive Councildesignated by the Lieutenant-Governor in Council under paragraph2(2)(b), for a term of three years.5(a) Under subsection 2(1) and paragraph 2(2)(c) of the Researchand Productivity Council Act, the Lieutenant-Governor in Council ap-points Dr. Peter Lewell as a person nominated by the Premier of NewBrunswick, for a term of three years.5(b) Under subsection 3(1) of the Research and Productivity CouncilAct, the Lieutenant-Governor in Council designates Dr. Peter Lewell toserve as the Executive Director of the Council.6. Under subsection 2(1) and paragraph 2(2)(d) of the Research andProductivity Council Act, the Lieutenant-Governor in Council appointsJean Boudreau as a member serving as a consulting engineer from anassociation of consulting engineering firms in New Brunswick nomi-nated by the member of the Executive Council, designated by theLieutenant-Governor in Council under paragraph 2(2)(d), for a term ofthree years.7. Under section 2(1) of the Research and Productivity Council Act,the Lieutenant-Governor in Council appoints the following persons asmembers of the Council, for a term of three years:

(a) Kim LaPointe ;(b) Adeline Misener;(c) Dr. Truong Vo-Van;(d) Greg Kealey;(e) William Jones;(f) Alan Ritchie;(g) William Borland;

Orders in Council

LE 19 DÉCEMBRE 20022002 - 453

En vertu de l’alinéa 6(1)b) de la Loi sur le Conseil des arts duNouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme lespersonnes suivantes membres du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick :

a) Paul Daigle, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), pour unmandat de trois ans; etb) Ludmila Knezkova-Hussey, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), pour un mandat de deux ans.

La lieutenante-gouverneure, Marilyn Trenholme Counsell

__________________

LE 19 DÉCEMBRE 20022002 - 454

1. En vertu de l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur le Conseil de la rechercheet de la productivité, le lieutenant-gouverneur en conseil désignel’Agence de promotion économique du Canada atlantique comme l’or-ganisme du gouvernement du Canada pouvant proposer la nominationd’une personne à titre de membre du Conseil en vertu dudit alinéa.2. En vertu des alinéas 2(2)b) et 2(2)d) de la Loi sur le Conseil de larecherche et de la productivité, le lieutenant-gouverneur en conseil dé-signe le ministre d’Entreprises Nouveau-Brunswick comme le membredu Conseil exécutif ayant le pouvoir de proposer la nomination de per-sonnes à titre de membre du Conseil en vertu desdits alinéas.3. En vertu du paragraphe 2(1) et de l’alinéa 2(2)a) de la Loi sur leConseil de la recherche et de la productivité, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme Brian Dick à titre de personne nommée par l’organ-isme désigné du gouvernement du Canada, pour un mandat de troisans.4. En vertu du paragraphe 2(1) et de l’alinéa 2(2)b) de la Loi sur leConseil de la recherche et de la productivité, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme Jacques Dubé, sous-ministre d’EntreprisesNouveau-Brunswick, membre du Conseil nommé par le membre duConseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil envertu de l’alinéa 2(2)b), pour un mandat de trois ans.5a) En vertu du paragraphe 2(1) et de l’alinéa 2(2)c) de la Loi sur leConseil de la recherche et de la productivité, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme Peter Lewell à titre de personne nommée par le pre-mier ministre du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans.5b) En vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Conseil de la recher-che et de la productivité, le lieutenant-gouverneur en conseil désignePeter Lewell à titre de directeur général du Conseil.6. En vertu du paragraphe 2(1) et de l’alinéa 2(2)d) de la Loi sur leConseil de la recherche et de la productivité, le lieutenant-gouverneuren conseil nomme Jean Boudreau membre à titre d’ingénieur-conseilprovenant d’une association de bureaux d’ingénieurs-conseil duNouveau-Brunswick nommé par le membre du Conseil exécutifdésigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa2(2)d), pour un mandat de trois ans.7. En vertu de l’article 2(1) de la Loi sur le Conseil de la recherche etde la productivité, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les per-sonnes suivantes membres du Conseil pour un mandat de trois ans :

a) Kim LaPointe;b) Adeline Misener;c) Truong Vo-Van;d) Greg Kealey;e) William Jones;f) Alan Ritchie;g) William Borland;

Décrets en conseil

Page 3: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 67 Gazette royale — 22 janvier 2003

(h) Gilles Volpé; (i) Sylvain R. Poirier; and(j) Wendy Ryan.

8. Under subsections 2(1) and 3(3) of the Research and ProductivityCouncil Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Dr. KnutGrotterod as a member and Chairman of the Council, for a term of threeyears.

Marilyn Trenholme Counsell, Lieutenant-Governor

_________________

DECEMBER 19, 20022002-458

Under subsections 3(2) and 3(6) of the Electric Power Act, theLieutenant-Governor in Council designates Leon Furlong as ActingChairman of the Board of Directors of the New Brunswick PowerCorporation, on an interim basis, effective January 1, 2003.

Marilyn Trenholme Counsell, Lieutenant-Governor

NOTICE OF LEGISLATIONTAKE NOTICE that the Anglican Diocese of Fredericton, 115 ChurchStreet, Fredericton, New Brunswick, E3B 4C8, intends to apply to thecurrent or next session of the Legislative Assembly of the Province ofNew Brunswick for the enactment of a Private Bill entitled “The Angli-can Church Act, 2003”.

The nature and object of the Bill is to replace the existing “Church ofEngland Act 1942”.DATED at Fredericton, New Brunswick this 6th day of January, 2003.

The Venerable Claude W Miller, Secretary, Diocese of Fredericton,115 Church Street, Fredericton, New Brunswick, E3B 4C8

Legislative Assembly

h) Gilles Volpé; i) Sylvain R. Poirier; etj) Wendy Ryan.

8. En vertu des paragraphes 2(1) et 3(3) de la Loi sur le Conseil de larecherche et de la productivité, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme Knut Grotterod membre et président du Conseil pour un man-dat de trois ans.

La lieutenante-gouverneure, Marilyn Trenholme Counsell

__________________

LE 19 DÉCEMBRE 20022002 - 458

En vertu des paragraphes 3(2) et 3(6) de la Loi sur l’énergie électrique,le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par intérim, Leon Furlongprésident du conseil d’administration de la Société d’énergie duNouveau-Brunswick, à compter du 1 janvier 2003.

La lieutenante-gouverneure, Marilyn Trenholme Counsell

AVIS DE PRÉSENTATION D’UN PROJET DE LOISACHEZ PAR LES PRÉSENTES que le Synode du diocèse deFredericton, 115, rue Church, Fredericton (Nouveau-Brunswick)E3B 4C8, a l’intention de demander à la session en cours ou à la pro-chaine session de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé intitulé « Loi de 2003 surl’Église Anglicane ».L’intention de cette loi privée est le remplacer l’existante « Church ofEngland Act 1942 ». FAIT à Fredericton, au Nouveau-Brunswick le 6 janvier 2003.

Le vénérable Claude W Miller, Secrétaire du diocèse de Fredericton,115, rue Church, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 4C8

Assemblée législative

STATELY ELM LAWN CARE INC. 14, allée Sinclair Lane Fredericton 603825 2002 12 18Fredericton, NB E3C 1J2

603937 N.B. Inc. 433, route King George Highway Miramichi 603937 2002 11 19Miramichi, NB E1V 1L7

604106 NB Ltd. 156, rue Alma Street Moncton 604106 2002 11 26Moncton, NB E1C 4Y7

604278 N.B. INC. 10, rue du Ruisseau Street Lamèque 604278 2002 12 10Lamèque, NB E8T 1L8

Dooly’s Bridgewater Ltd. 122, chemin Old Hampton Road Rothesay 604319 2002 12 09Rothesay, NB E2E 2N5

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commercia-les, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

Page 4: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 68 Gazette royale — 22 janvier 2003

NORTHWEST PLAZA LTD. Eddy & Downs Fredericton 604321 2002 12 0965, rue Regent Street, bureau / Suite 210C.P. / P.O. Box 1205, succ. / Stn. AFredericton, NB E3B 5C8

BRUNSWICK VALLEY LUMBER INC. 72, allée Woodbine Lane Upper Kingsclear 604323 2002 12 16Upper Kingsclear, NB E3E 1S1

MAK-KAM MEDICAL PROFESSIONAL 114, rue Roseberry Street Campbellton 604357 2002 12 11CORPORATION C.P. / P.O. Box 1002

Campbellton, NB E3N 2G4

DÉPANNEUR LAMÈQUE INC. 10, rue du Ruisseau Street Lamèque 604360 2002 12 10Lamèque, NB E8T 1L8

Wilson Brook Holdings Limited 300, rue Union Street Saint John 604370 2002 12 11Saint John, NB E2L 4M3

604371 N.B. Ltd. 119, chemin Whitehead Road Whitehead Island 604371 2002 12 11Whitehead Island, NB E5G 1K3

Northside Auto Inc. 1219, chemin Mountain Road Moncton 604372 2002 12 31Moncton, NB E1C 2T4

Queens Ridge Woodworking Inc. 276, chemin Queens Ridge Road Clarendon 604411 2002 12 12Clarendon, NB E5K 4G2

Head-On Collision Inc. 44, rue Greenwood Street Saint John 604412 2002 12 12Saint John, NB E2N 1C9

Ter-Ann Sales Ltd. 44, promenade Monaco Drive Rothesay 604413 2002 12 12Rothesay, NB E2E 2N9

Bonded Cleaning Services Inc. 16, rue Main Street, 2e étage / 2nd Floor Saint John 604414 2002 12 12Saint John, NB E2K 1H1

Copper Ledge Holdings Inc. 105, rue Moffatt Street Woodstock 604422 2002 12 12Woodstock, NB E7M 2H5

Maritime Dimension Hardwoods Inc. 105, rue Moffatt Street Woodstock 604423 2002 12 12Woodstock, NB E7M 2H5

Dr. D.V. Brien Professional Corporation 38, promenade Bell Manor Drive Saint John 604427 2002 12 13Saint John, NB E2K 2J4

Montary Solutions Corporation 570, rue Queen Street, bureau / Suite 600 Fredericton 604428 2002 12 13Fredericton, NB E3B 5Z6

Nôgmaeoi Inc. 47, chemin Church Road Eel Ground 604432 2002 12 13Eel Ground, NB E1V 4E6

GLENHARLEN INC. 336, chemin Lincoln Road Fredericton 604442 2002 12 16C.P. / P.O. Box 1056Fredericton, NB E3B 5C2

Build-A-Bear Workshop Canada, Ltd. James D. Murphy Saint John 604448 2002 12 1644, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

Dynamic Essentials of Canada Inc. McInnes Cooper Fredericton 604455 2002 12 16570, rue Queen Street, bureau / Suite 600Fredericton, NB E3B 5A6

Wilshaw & Associates Professional Corporation Maggie A. Coffin Prowse Saint John 604459 2002 12 16133, rue Prince William Street, bureau / Suite 801C.P. / P.O. Box 6787, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S2

604472 N.B. LTD. 14, promenade Rosemere Drive Grand Bay- 604472 2002 12 18Grand Bay-Westfield, NB E5K 1Y4 Westfield

Intelisys Acquisition Inc. Peter M. Klohn Saint John 604494 2002 12 1744, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

Page 5: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 69 Gazette royale — 22 janvier 2003

NEWMANS JACK OF ALL TRADES INC. 13, rue Renfrew Street Petitcodiac 604501 2002 12 18Petitcodiac, NB E4Z 5S4

604533 N.B. Ltd. 207, promenade Sunset Drive Fredericton 604533 2002 12 27Fredericton, NB E3A 1A4

Extreme Cleaning Products Ltd 840, chemin Hanwell Road Fredericton 604538 2002 12 19Fredericton, NB E3B 6A2

JRMPG Limited 310, avenue Woodward Avenue, bureau / Suite 1101 Saint John 604580 2002 12 20Saint John, NB E2K 2L1

JAC REALCO LTD. 820, rue Prospect Street Fredericton 604591 2002 12 20C.P. / P.O. Box 88Fredericton, NB E3B 4Z2

Imperial Distributors Inc. 40, rue Industrial Park Street Richibucto 604599 2002 12 23Richibucto, NB E4W 4A4

SPRING FRESHET INC. 261, chemin Restigouche Road Oromocto 604625 2002 12 23Oromocto, NB E2V 2H1

JFD HOLDINGS LTD. 891, promenade Riverside Drive Fredericton 604637 2002 12 27C.P. / P.O. Box 68Fredericton, NB E3B 4Y2

ROSS DRUG NORTH LTD. 402, rue Queen Street Fredericton 604640 2002 12 24Fredericton, NB E3B 1B6

604641 N.B. LTD. 28, rue Sydney Street Saint John 604641 2002 12 30Saint John, NB E2L 4R8

Dr. Mary E. Jarratt Professional Corporation 640, rue Prospect Street Fredericton 604646 2002 12 30Fredericton, NB E3B 9M7

SLOCUM’S FARM FRESH PRODUCE LTD. 6179, route / Highway 2 Waterborough 604655 2002 12 27Waterborough, NB E4C 2Y3

Dr. F. Bruce Dykeman Professional Corporation 1, chemin Marr Road, bureau / Suite 102 Rothesay 604656 2002 12 27Rothesay, NB E2E 3L4

MUSCLES AT EASE INC. 515, cour Beaverbrook Court Fredericton 604674 2002 12 30Fredericton, NB E3B 1X6

ARI’S IMPRESSIONS INC. 96, cour Meadowgreen Court Fredericton 604680 2002 12 31Fredericton, NB E3B 5L8

604685 N.B. LTD. 137, croissant Barton Crescent Fredericton 604685 03/01/02Fredericton, NB E3A 4Z6

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on December 31, 2002 under the name of “ARI’S IMPRESSIONS INC.”, being corporation #604680, notice isgiven that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the date of the incorporation from “December 31,2002” to “January 1, 2003”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 31 décembre 2002 à « ARI’S IMPRESSIONS INC. », dont le numéro de corporationest 604680, le Directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat corrigé faisant passer la date de constitution en corporation du « 31 décembre2002 » au « 1er janvier 2003 ».

_____________________________________________________

604303 N.B. Inc. 40, rue Industrial Street Richibucto Canada 604303 2002 12 23Richibucto, NB E4W 4A4

Design Krolon Ltée/ 40, rue Industrial Street Richibucto Canada 604600 2002 12 23Krolon Design Ltd. Richibucto, NB E4A 4W4

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpo-rations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de prorogation a été émis à :

Previous ReferenceJurisdiction Number Date

Registered Office Compétence Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré antérieure référence année mois jour

Page 6: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 70 Gazette royale — 22 janvier 2003

Boflex Inc. 40, rue Industrial Street Richibucto Canada 604601 2002 12 23Richibucto, NB E4A 4W4

_____________________________________________________

BELLEISLE FARMS LTD. 001745 2002 12 27

ROBLYNN BUILDING SUPPLIES & RENTALS LTD. 014208 2002 12 23

A.J.R. Pharmacy Ltd. 033655 2002 12 16

BELLEISLE FOODS LTD. 035837 2002 12 27

BRIMSACLE & RAILL INSURANCE LTD. 037651 2002 11 20

IMPERIAL TILE & CONCRETE LTD. 044728 2002 12 10

DR. JEAN-MARC CORMIER CORPORATION PROFESSIONNELLE INC./ 053442 2002 11 25DR. JEAN-MARC CORMIER PROFESSIONAL CORPORATION INC.

MANANOOK AQUACULTURE LTD. 055509 2002 12 18

056416 N.B. LTD. 056416 2002 12 27

056417 N.B. LTD. 056417 2002 12 27

056418 N.B. LTD. 056418 2002 12 27

ACTION RADIATOR & GLASS MASTER INC. 503832 2002 11 19

Ranch a Paul Inc. 515894 2002 11 27

WINDYMT FARM LTD. 602048 2002 12 27

_____________________________________________________

Dr. Donald E. Pelkey Professional Corporation ORSUR MANAGEMENT LTD. 012627 2003 01 01

Ammon Precast Concrete Products Limited WESTMORLAND AUTO BODY LTD. 044486 2003 01 01

504853 N.B. INC. ONE STOP MINI-STORAGE INC. 504853 2002 12 16

Wilcox Investments Ltd. Wilcox Motors Ltd. 509812 2003 01 02

Rockport Developments Inc. HARIM CONSTRUCTION COMPANY LTD. 513054 2002 12 18

Precision Food Group Ltd. 602833 N.B. Ltd. 602833 2002 11 25

STOCKFORD HOLDINGS LTD. 056369 NB LTD. 604572 2003 01 02

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 7: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 71 Gazette royale — 22 janvier 2003

CGC INC. CGC INC. Édifice de la banque Royale / Saint John 604467 2003 01 01DONN CANADA LIMITED/ Royal Bank BuildingDONN CANADA LIMITEE 3e étage / 3rd Floor

85, rue Charlotte StreetC.P. / P.O. Box 6010Succursale / Station ASaint John, NB E2L 4R5

DOLAN’S DOOR AND DOLAN’S DOOR AND Unité / Unit A Riverview 604469 2002 12 31HARDWARE CONSULTANTS HARDWARE CONSULTANTS 15, promenade Biggs DriveLTD. LTD. Riverview, NB E1B 3Y8

DOLAN’S HOLDINGS LTD.

BENNY POIRIER CO. LTÉE BENNY POIRIER CO. LTEE. 962, avenue des Balmoral 604470 2003 01 01GALERIE BALMORAL INC. Pionniers Avenue

Balmoral, NB E8E 1E5

WILSON REALTY GROUP LTD. WILSON REALTY GROUP LTD. 26, ch. Westmount Rd. Saint John 604486 2003 01 01WILSON SECURITY LIMITED Saint John, NB E2M 6L6

HARTLAND PROPERTIES Hartland Properties Limited Unité / Unit 1 Hartland 604511 2002 12 31LIMITED 511891 N.B. Ltd. 538, rue Main Street

Hartland, NB E7P 2N5

Wilson Insurance Ltd. FRANK I. MORRISON & 404, rue Queen Street Fredericton 604559 2003 01 01SON (1986) LTD. C.P. / P.O. Box 367WILSON INSURANCE LTD. Fredericton, NB E3B 4Z9

Dumar Enterprises Ltd. DUMAR ENTERPRISES C. Paul W. Smith Saint John 604564 2003 01 01ACQUISITION LTD. 44, côte Chipman HillD & G Precision Bureau / Suite 1000Machining Inc. C.P. / P.O. Box 7289

Succursale / Station ASaint John, NB E2L 4S6

Armour Transport Inc. Armour Transport Inc. 689, prom. Edinburgh Dr. Moncton 604569 2002 12 28053153 N.B. LTD. Moncton, NB E1E 2L4

Armour Realty Inc. Armour Realty Inc. 689, prom. Edinburgh Dr. Moncton 604570 2002 12 28054021 N.B. LTD. Moncton, NB E1E 2L4

056369 NB LTD. 056369 NB LTD. 78, rue Winter Street Sussex 604572 2003 01 02STOCKFORD HOLDINGS LTD. C.P. / P.O. Box 4369

Sussex, NB E4E 5L5

_____________________________________________________

J. P. DUCLOS & FILS LIMITEE C.P. / P.O. Box 92 Saint-Isidore 005280 2002 11 22Saint-Isidore, NB E0B 2L0

KELLY’S AUTOMOTIVE APPRAISALS LTD. 132, chemin Golf Club Road Fredericton 009066 2002 12 19Fredericton, NB E3B 5M6

C N B HOLDINGS LTD. 301, rue Wellington Street Chatham 034616 2002 11 29Chatham, NB E1N 1P1

BOSTON FISH & FRIES LTD. 45, promenade Monaco Drive Fairvale 051073 2002 12 02Fairvale, NB E2E 2N9

DORION ASPHALT LTEE/LTD. R. R. 1, empl. 6, boîte 5 / RR 1, Site 6, Box 5 Notre-Dame-de-Kent 509171 2002 11 25Notre-Dame-de-Kent, NB E0A 2G0

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Address Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Address / Adresse Bureau enregistré référence année mois jour

Page 8: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 72 Gazette royale — 22 janvier 2003

Roch Larivee & Son Ltd. 203, chemin Restigouche Road Oromocto 509525 2002 11 21Oromocto, NB E2V 2H1

EGROUPS INTERNATIONAL 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor Saint John 512012 2002 11 20(CANADA) INC. Saint John, NB E2L 2A9

ALEGRIA TOURS LTD. 3292, route / Highway 625 Boiestown 512601 2002 11 25Boiestown, NB E6A 2A2

_____________________________________________________

VITALITY FOODSERVICE CANADA CO. Nouvelle-Écosse / Willard M. Jenkins 604167 2002 11 28Nova Scotia 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

MACKAY & HUGHES (1973) LIMITED Ontario Darrell J. Stephenson 604194 2002 11 2944, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th FloorC.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

2762617 Canada Inc. Canada C. Paul W. Smith 604645 2002 12 2444, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

Supremex Inc. Canada Franklin O. Leger 604668 2002 12 301, Brunswick Square, bureau / Suite 1500C.P. / P.O. Box 1324Saint John, NB E2L 4H8

_____________________________________________________

PROCOR LIMITED Canada Willard M. Jenkins 018264 2002 12 11 2003 04 04LYNROSS HOLDINGS LTD Canada Sean F. Perry 018947 2002 12 11 2003 04 04LES IMMEUBLES TRANSFORCE INC. Québec / Quebec D. Hayward Aiton 072235 2002 12 11 2003 04 04TRANSFORCE REAL ESTATE INC.R. BECKER ENTERPRISES INC. Michigan Margo Adair 072903 2002 12 11 2003 04 04ALBERMARK CONSTRUCTION LTD Ontario Léona Noël 073777 2002 12 11 2003 04 04CROSBIE INDUSTRIAL Terre-Neuve / Brian A. Stephenson 073909 2002 12 11 2003 04 04SERVICES LIMITED NewfoundlandAVCO FINANCIAL SERVICES Ontario William T. Walker 073929 2002 12 11 2003 04 04REALTY LIMITEDTRANSPORT CABANO-KINGSWAY Québec / Quebec D. Hayward Aiton 074210 2002 12 11 2003 04 04INC./CABANO-KINGSWAY TRANSPORT INC.The Night Shift Answering Colombie-Britannique / Gregory Michael Darychuck 076037 2002 12 11 2003 04 04Service Ltd. British ColumbiaR.L.B. ENTERPRISES LIMITED Nouvelle-Écosse / William H. Teed 076065 2002 12 11 2003 04 04

Nova ScotiaJOHNSON CONTROLS LTD./ Ontario Willard M. Jenkins 076262 2002 12 11 2003 04 04SOCIETE DE CONTROLE JOHNSON LTEECUSTOMER CARE INSURANCE Canada Lynne M. Burnham 076278 2002 12 11 2003 04 04AGENCY LIMITEDFIRST CANADIAN HOME Ontario D. Hayward Aiton 076488 2002 12 11 2003 04 04WARRANTY LIMITEDAshland Canada Inc. Ontario John M. Hanson 076545 2002 12 11 2003 04 04

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, the Director has made a decision to cancel the registrationof the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,le Directeur a décidé d’annuler l’enregistrement des corporations ex-traprovinciales suivantes :

Proposed CancellationReference Notice Date Date / Date deNumber Date de l’avis l’annulation projetée

Jurisdiction Agent Numéro de Year Month Day Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant référence année mois jour année mois jour

Page 9: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 73 Gazette royale — 22 janvier 2003

Maine Packers Inc. Maine Margo Adair 076634 2002 12 11 2003 04 04DOCUMENT SERVICES Nouvelle-Écosse / Peter M. Klohn 076779 2002 12 11 2003 04 04INTERNATIONAL COMPANY Nova ScotiaRNG Group Inc. Groupe RNG Inc. Canada C. Paul W. Smith 076818 2002 12 11 2003 04 04MULTISODAS INC. Québec / Quebec M. Armand Savoie 077379 2002 12 11 2003 04 04CRESTSTREET 2000 Ontario Donald F. MacGowan 077993 2002 12 11 2003 04 04MANAGEMENT LIMITED/GESTION CRESTSTREET 2000 LIMITÉECLEARNET INC. Canada C. Paul W. Smith 078108 2002 12 11 2003 04 04KILCULLEN MARKETING INC. Ontario T. Gregory Riordon 602096 2002 12 11 2003 04 04

_____________________________________________________

FONDATION BOURSES D’ETUDES COCAGNE INC. FONDATION COCAGNE INC. 024334 2002 12 11

Two Bit Entertainment William Toner 98, promenade Greenwood Drive 603797 2002 11 01Fredericton, NB E3A 3T5

Galbraith’s Stables Brian Galbraith 7678, route / Highway 102 603867 2002 11 06Lower Greenwich, NB E5K 4G5

CIBC Insurance CIBC Life Insurance Company James D. Murphy 603874 2002 11 06Limited 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000Compagnie D’Assurance Vie C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ACIBC Limitee Saint John, NB E2L 4S6

CIBC Trust CIBC Trust Corporation James D. Murphy 603875 2002 11 0644, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

HUNTER LAKE TAMARACK HUNTER’S VENTURES 173, chemin Hunter Lake Road 603896 2002 11 07FLOORING LIMITED Upper Golden Grove, NB E2L 3B4

QuikFix Vending Service Nicole Grant l57, croissant Ashley Crescent 603897 2002 11 07Moncton, NB E1G 1R5

Location Sénéchal & Fils Daily Rentals MAURICE G. SENECHAL LTD.- 260, chemin Madawaska Road 603905 2002 11 08MAURICE G. SENECHAL LTEE Grand-Sault / Grand Falls, NB E3Y 1A4

GALLERIE D’ART ALICE Alice Caissie 14, rue Caissie Street 603906 2002 11 08CAISSIE ART GALLERY Saint-Antoine, NB E4V 3J9

EXOTIC LIFESTYLE NATURAL Alice Caissie 14, rue Caissie Street 603907 2002 11 12PRODUCTS Saint-Antoine, NB E4V 3J9

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,supplementary letters patent, which include a change in name,have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettrespatentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,ont été émises à :

DateNew Name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 10: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 74 Gazette royale — 22 janvier 2003

The DFS Group NEBS BUSINESS PRODUCTS C. Paul W. Smith 603935 2002 11 12LIMITED/ 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th FloorPRODUITS D’AFFAIRES NEBS C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ALIMITEE Saint John, NB E2L 4S6

DFS Business Forms NEBS BUSINESS PRODUCTS C. Paul W. Smith 603936 2002 11 12LIMITED/ 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th FloorPRODUITS D’AFFAIRES NEBS C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ALIMITEE Saint John, NB E2L 4S6

THE GREENHOUSE WINDOW Joanna R. Dubois 618, rue Main Street 603963 2002 11 17Woodstock, NB E7M 2C4

S. Cooper Carrier Sylvain Desjardins 509, rue Principale Street 604009 2002 11 18Neguac, NB E9G 1R9

BROWN’S SERVICE CENTER Viola Brown 62, promenade Elmwood Drive 604021 2002 11 19Moncton, NB E1A 3W8

JUST ’N’ TIME SERVICES Marc J. Brun 304, rue Manon Street 604022 2002 11 19Dieppe, NB E1A 6W1

FLO’S CAMERA/FREELANCE Flora Guitard 53, promenade Curry Drive 604034 2002 12 12PHOTOGRAPHY Belledune, NB E8G 2A4

GE Consumer Products Canada General Electric Canada Inc. C. Paul W. Smith 604036 2002 11 20Generale Electrique du 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th FloorCanada Inc. C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A

Saint John, NB E2L 4S6

GE Consumer Products General Electric Canada Inc. C. Paul W. Smith 604037 2002 11 20Generale Electrique du 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th FloorCanada Inc. C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. A

Saint John, NB E2L 4S6

Export Growth Associates Eric Anderson 357, promenade McAllister Drive 604045 2002 11 20Riverview, NB E1B 1T9

Voyages Tracadie Travel Enrg. BURGESS TRAVEL LIMITED 339, rue du Moulin Street, unité / Unit 5 604061 2002 11 21Tracadie-Sheila, NB E1X 1A4

DUKANE COMMUNICATIONS SPX CANADA INC. Donald F. MacGowan 604067 2002 11 21SYSTEMS 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

DB & HERTZ ENREGISTREMENT Marc Bédard 119, avenue Portage Avenue 604079 2002 12 01SONORE Grande-Anse, NB E8N 2K8

Tyler Entertainment Studios Josette Cormier 14, rue Church Street, bureau / Suite 303 604087 2002 11 25Moncton, NB E1C 4Y9

CBDC WESTMORLAND ALBERT LEAD CORPORATION 11 B, rue Hamilton Street 604097 2002 11 25CLÉ INC. Shediac, NB E4P 1W1

FRANK’S MUSIC FRAN-AN ENTERPRISES LTD. 477, rue Paul Street 604098 2002 11 25Dieppe, NB E1A 4X5

C A THOMPSON CONSTRUCTION Chris Aaron Thompson 315, chemin Meenans Cove Road 604160 2002 11 28Quispamsis, NB E2G 1A2

Kobi Hair Richard Linteau 1292, chemin Mountain Road 604176 2003 01 01Moncton, NB E1C 8S9

LA FONTAINE ESTHÉTIQUE Linda Fontaine 4550, rue Principale Street, unité / Unit 3 604185 2002 11 29Saint-Antoine, NB E4V 1R3

HUGHES FARMS MACKAY & HUGHES (1973) Darrell J. Stephenson 604195 2002 11 29LIMITED 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

Golden Harmony Jacy William Golden 15, chemin Greens Point Road 604209 2002 12 02L’Etete, NB E5C 2N4

Conservation Economy Rob Rainer 29, allée Potters Lane 604231 2002 12 02Bocabec, NB E5B 3P4

Page 11: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 75 Gazette royale — 22 janvier 2003

Cherry Hill Horse Loggers Paul Andrew Jaehrling 2898, chemin Lower Cambridge Road 604237 2002 12 03Cambridge-Narrows, NB E4C 1R4

The Bull Stops Here 502920 N.B. INC. 162, chemin Chartersville Road 604243 2002 12 03Dieppe, NB E1A 1K4

THE DATA GROUP OF COMPANIES DATA BUSINESS FORMS C. Paul W. Smith 604251 2002 12 03LIMITED 44, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

Miramichi Old Country Homestead Lodge Cheryl Cosgrove 949, route / Highway 118 NE 604257 2002 12 04Gray Rapids, NB E9B 1R8

CAMELOT LIFESTYLES William Needham 330, rue Radio Street 604270 2002 12 04Miramichi, NB E1V 2W6

Gretzky Construction & Gretzky Dupuis 17, chemin Cornwall Road 604305 2002 12 06Consulting Services Shediac, NB E4P 1N8

Robichaud Funeral Home/ MEMORIAL GARDENS David G. Barry 604340 2002 12 09Maison Funeraire CANADA LIMITED - 3e étage / 3rd FloorRobichaud (Tracadie) LES JARDINS 85, rue Charlotte Street

COMMEMORATIFS Saint John, NB E2L 2J2DU CANADA LIMITÉE

Castle Funeral Home (Fallsview Chapel) MEMORIAL GARDENS David G. Barry 604341 2002 12 09CANADA LIMITED - 3e étage / 3rd FloorLES JARDINS 85, rue Charlotte StreetCOMMEMORATIFS Saint John, NB E2L 2J2DU CANADA LIMITÉE

Castle Funeral Home (Kings Chapel) MEMORIAL GARDENS David G. Barry 604342 2002 12 09CANADA LIMITED - 3e étage / 3rd FloorLES JARDINS 85, rue Charlotte StreetCOMMEMORATIFS Saint John, NB E2L 2J2DU CANADA LIMITÉE

ASTRO WEB DESIGN Sherry Adams 114, rue Main Street 604364 2002 12 11Petitcodiac, NB E4Z 4M4

GRAND LAKE PARADISE VILLA 509823 N.B. Inc. 781, promenade Northside Drive 604375 2002 12 12Minto, NB E4B 3C7

ENTERPRISE FUNDY/ FUNDY COMMUNITY 717, rue Main Street, unité / Unit 1 604378 2002 12 11ENTREPRISE FUNDY ECONOMIC DEVELOPMENT Sussex, NB E4E 7H7

AGENCY INC.

Felicam Productions Alison Hart 21, croissant Barrington Crescent 604390 2002 12 10Moncton, NB E1G 4S8

Byte Busters Computing Solutions Stephen Ménard 181, chemin Garnett Road 604401 2002 12 12Saint John, NB E2J 3C4

Westmorland Auto Body Ammon Precast Concrete 618, chemin Ammon Road 604408 03/01/01Products Limited Irishtown, NB E1H 2E1

BEN’S Canada Bread Atlantic Limited 235, prolongement de la rue Botsford / 604416 2002 12 12235 Botsford Street ExtensionMoncton, NB E1C 1S3

EASTERN BAKERIES/ Canada Bread Atlantic Limited 235, prolongement de la rue Botsford / 604417 2002 12 12BOULANGERIES EASTERN 235 Botsford Street Extension

Moncton, NB E1C 1S3

GRAND FALLS CENTRAL BAKERY Canada Bread Atlantic Limited Chemin Saint-André Road 604419 2002 12 12RR 4Grand-Sault / Grand Falls, NB E3Z 1C9

CABIN BAKING COMPANY Canada Bread Atlantic Limited 235, prolongement de la rue Botsford / 604420 2002 12 12235 Botsford Street ExtensionMoncton, NB E1C 1S3

BAKERY TRANSPORT Canada Bread Atlantic Limited 235, prolongement de la rue Botsford / 604421 2002 12 12235 Botsford Street ExtensionMoncton, NB E1C 1S3

Page 12: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 76 Gazette royale — 22 janvier 2003

Double G Auto Ginette Losier 2144, route / Highway 160 604425 2002 12 13Saint-Sauveur, NB E8L 1P2

Down East Walking Sticks Barrie Bochoff 58, promenade Riverview Drive 604457 2002 12 17Somerville, NB E7P 3B4

MOI ET MES SOULIERS DR. LISA M. LIRETTE 352, rue Main Street 604479 2002 12 17PROFESSIONAL Shediac, NB E4P 2E8CORPORATION

Betty’s Corner Cafe Gregory Melanson 179, rue Prince William Street 604497 2002 12 18Saint John, NB E2L 2B4

FLAT FIXER Gilles Michaud 421, rue Principale Street 604502 2002 12 18Saint-Léonard, NB E7E 2J1

M.C. Richard Body Shop M. C. RICHARD INC. 339, chemin Violette Station Road 604503 2002 12 18DSL de Drummond / LSD of Drummond, NB E3Y 2R6

Pete Gibson Digital Video Recorder Sales Pete Gibson 82, promenade Greenwood Drive 604507 2002 12 18Moncton, NB E1E 3B7

XLR8 Publications 603609 N.B. LTD. 102, promenade Palisade Drive 604522 2002 12 18Moncton, NB E1A 5K2

DAD’S DELI Heidi Peter-Paul 127–1, rue Main Street 604531 2002 12 19Rexton, NB E4W 2A3

Windsor Castle Pub GRADUATE STUDENT 676, rue Windsor Street 604535 2002 12 19ASSOCIATION OF THE Fredericton, NB E3B 4G4UNIVERSITY OF NEWBRUNSWICK INC.

The Bonnie Lee Bonnie Weir 380, rue Main Street, unité / Unit 1 604545 2003 01 01Hartland, NB E7P 2N2

Esporta of Greater Moncton Richard Trowsdale 171, boulevard Millineum Boulevard 604578 2003 01 01Moncton, NB E1E 2G7

Soaring Timber Creations Peter denAdmirant 5004, route / Highway 112 604596 2002 12 20Harewood, NB E4Z 4H7

Ellie’s Hair Port Ellie Stewart 49, rue Queen Street 604661 2002 12 30Minto, NB E4B 3P1

Dort Financial Planning Services Gerald Joseph Dort 31, rue Wright Street 604676 2002 12 31Saint John, NB E2K 3Z3

Leon Christie Racing Derek Christie 42, cour Abbott Court, app. / Apt. 13 604679 2002 12 31Leon Christie Fredericton, NB E3B 5W3

Lundrigan Technical Services Bruce Lundrigan 599, rue Chestnut Street 604684 2002 12 31Fredericton, NB E3B 3W1

J. J. JANITORIAL 604685 N.B. LTD. 137, croissant Barton Crescent 604686 2003 01 02Fredericton, NB E3A 4Z6

D. J. PROMOTIONS 604685 N.B. LTD. 137, croissant Barton Crescent 604687 2003 01 02Fredericton, NB E3A 4Z6

_____________________________________________________

FAIR HAVEN MEMORIAL GARDENS MEMORIAL GARDENS CANADA David G. Barry 304097 2002 12 09LIMITED - 3e étage / 3rd FloorLES JARDINS COMMEMORATIFS 85, rue Charlotte StreetDU CANADA LIMITÉE Saint John, NB E2L 2J2

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number Date

Registrant of Certificate Adresse du commerce ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Enregistreur du certificat du représentant référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 77 Gazette royale — 22 janvier 2003

LABATT’S NEW BRUNSWICK Labatt Brewing Company Limited/ Willard M. Jenkins 305152 2002 12 11BREWERY La Brasserie Labatt Limitee 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

KEITH’S BREWERY Labatt Brewing Company Limited/ Willard M. Jenkins 311194 2002 12 11La Brasserie Labatt Limitee 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

SCHOONER BREWERIES Labatt Brewing Company Limited/ Willard M. Jenkins 319235 2002 12 11La Brasserie Labatt Limitee 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

DEWALT INDUSTRIAL TOOL BLACK & DECKER CANADA INC. Rodney D. Gould 329874 2002 12 12COMPANY 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

GOOD-WEAR TREADERS BRIDGESTONE/FIRESTONE C. Paul W. Smith 330367 2002 12 04CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

CROWN TIRE SERVICE (ATLANTIC) BRIDGESTONE/FIRESTONE C. Paul W. Smith 330772 2002 12 04CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

PARDY’S TIRE SERVICE BRIDGESTONE/FIRESTONE C. Paul W. Smith 330773 2002 12 04CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

NEWFOUNDLAND TIRE BRIDGESTONE/FIRESTONE C. Paul W. Smith 330774 2002 12 04WHOLESALERS CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

SUPER TIRE BRIDGESTONE/FIRESTONE C. Paul W. Smith 330775 2002 12 04CANADA INC. 44, côte Chipman Hill, 10e étage / 10th Floor

C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

CASTLE FUNERAL HOMES MEMORIAL GARDENS CANADA David G. Barry 332596 2002 12 09LIMITED - 3e étage / 3rd FloorLES JARDINS COMMEMORATIFS 85, rue Charlotte StreetDU CANADA LIMITÉE Saint John, NB E2L 2J2

KINGS CHAPEL FUNERAL HOME & MEMORIAL GARDENS CANADA David G. Barry 336687 2002 12 09CREMATION CENTRE LIMITED - 3e étage / 3rd Floor

LES JARDINS COMMEMORATIFS 85, rue Charlotte StreetDU CANADA LIMITÉE Saint John, NB E2L 2J2

FALLSVIEW FUNERAL HOME & MEMORIAL GARDENS CANADA David G. Barry 336689 2002 12 09CREMATION CENTRE LIMITED - 3e étage / 3rd Floor

LES JARDINS COMMEMORATIFS 85, rue Charlotte StreetDU CANADA LIMITÉE Saint John, NB E2L 2J2

NOVA SCOTIA BREWERY Labatt Brewing Company Limited/ Willard M. Jenkins 336892 2002 12 11La Brasserie Labatt Limitee 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

ALEXANDER KEITH’S NOVA SCOTIA Labatt Brewing Company Limited/ Willard M. Jenkins 336893 2002 12 11BREWERY La Brasserie Labatt Limitee 40, rangée Wellington Row

C.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

ARBOR CREMATION CENTRE MEMORIAL GARDENS CANADA David G. Barry 337345 2002 12 09LIMITED - 3e étage / 3rd FloorLES JARDINS COMMEMORATIFS 85, rue Charlotte StreetDU CANADA LIMITÉE Saint John, NB E2L 2J2

BULGER FUNERAL HOME/ MEMORIAL GARDENS CANADA David G. Barry 338581 2002 12 09MAISON FUNERAIRE BULGER LIMITED – 3e étage / 3rd Floor

LES JARDINS COMMEMORATIFS 85, rue Charlotte StreetDU CANADA LIMITÉE Saint John, NB E2L 2J2

Page 14: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 78 Gazette royale — 22 janvier 2003

BAX GLOBAL BAX GLOBAL (CANADA) LTD. Frederick D. Toole 343047 2002 11 0144, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

HAWKSHOTS Michael A. Hawkins 13, avenue Iona Avenue 343117 2002 11 07Rothesay, NB E2E 3H6

FIDDLEHEAD FORGE Michael R. Cook 30, promenade Sunset Drive 343250 2002 12 05Lakeville Corner, NB E4B 1M6

_____________________________________________________

LABATT BREWING COMPANY Wallace Turnball 311663 2002 12 1140, rangée Wellington RowC.P. / P.O. Box 6850, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S3

THE GREENHOUSE WINDOW 618, rue Main Street 326460 2002 11 16C.P. / P.O. Box 412Woodstock, NB E0J 2B0

J.J. JANITORAL 137, croissant Barton Crescent 331000 2003 01 02Fredericton, NB E3A 4Z6

ARI’S IMPRESSIONS 96, cour Meadowgreen Court 332116 2002 12 31Fredericton, NB E3B 5L8

GE CAPITAL CANADA C. Paul W. Smith 340983 2002 11 2544, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

GE CAPITAL AUTOLEASE C. Paul W. Smith 340985 2002 11 2544, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

D. J. PROMOTIONS 137, croissant Barton Crescent 343718 2003 01 02Fredericton, NB E3A 4Z6

GE Capital Auto Financial Services C. Paul W. Smith 344909 2002 11 2544, côte Chipman Hill, bureau / Suite 1000C.P. / P.O. Box 7289, succ. / Stn. ASaint John, NB E2L 4S6

Ammon Precast Concrete Products 618, chemin Ammon Road 346356 2002 12 31Irishtown, NB E1H 2E1

Voyages Tracadie Travel Enrg. 339, rue du Moulin Street, unité / Unit 5 350012 2002 11 21Tracadie-Sheila, NB E1X 1A4

_____________________________________________________

Pro-Kin Rehab Sally Ann Stultz 95, rue Foundry Street 602085 2002 12 17Susan Darlene MacLean Boîte / Box 2

Moncton, NB E1C 5H7

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 79 Gazette royale — 22 janvier 2003

Gymnathec Dany Roy 1126, route / Highway 275 603695 2002 11 04Sylvain Mercier Saint-Arthur, NB E3N 5R3

Eden Outdoors Josh DuBois 3157, route / Highway 103 603868 2002 11 05Jonathan MacDonald Simonds, NB E7P 2Z1

Grandma’s Pantry Ellen Lourdes Bowes 278, rue Campbell Street 604177 2002 11 28Erin Colleen Bowes Miramichi, NB E1V 1R5

Churchland Estates Robert W. Brown 825, avenue McLeod Avenue 604187 2002 11 28Alfred Brown Fredericton, NB E3B 9V4

Core Agency Ian MacDonald 169 ½, chemin Mountain Road 604496 2002 12 17Jason Murray Moncton, NB E1C 2L1

TIME SAVOUR CATERER Yvette Marie Goguen 70, promenade Maplewood Drive 604664 2002 12 30Jean-Claude Lagacé Rusagonis, NB E3B 7Z1

_____________________________________________________

COVERVIEW FARM William Mitton 111, chemin Mitton Road 330285 2002 11 28Heather Mitton Riverview, NB E1B 5A8

_____________________________________________________

Double G Auto 2144, route / Highway 160 603104 2002 12 13Saint-Sauveur, NB E8L 1P2

THE DELI WAY 127, rue Main Street 604069 2002 12 19Rexton, NB E4W 2A3

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

DateAddress Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Adresse Numéro de référence année mois jour

NOTICE OF PUBLIC HEARINGNotice is given that a public hearing of the Municipal Capital Borrow-ing Board will be held - Monday February 10, 2003 at 2:00 p.m.,Marysville Place, Third Floor Conference Room, Fredericton, NB, tohear the following municipal application for authorization to borrowmoney for a capital expense:

Time Municipality Purpose Amount

2:05 p.m. Westmorland AlbertSolid Waste

Environmental Health Services

Commission Lease Equipment $745,000

2:15 p.m. Memramcook Protective ServicesEquipment $18,000

Municipal CapitalBorrowing Act

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUESachez que la Commission des emprunts de capitaux par les municipa-lités tiendra une audience publique le lundi 10 février 2003, à 14 h, àPlace Marysville, salle de conférence du troisième étage, Fredericton(N.-B.), pour entendre les demandes des municipalités suivantes visantl’autorisation d’emprunter des fonds en vue de dépenses en capital.

Heure Municipalité But Montant

14 h 5 Commission de gestiondes déchets solides de

Services d’hygièneenvironnementale

Westmorland-Albert Location de matériel 745 000 $

14 h 15 Memramcook Services de protectionMatériel 18 000 $

Loi sur les emprunts decapitaux par les municipalités

Page 16: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 80 Gazette royale — 22 janvier 2003

Objections to these applications may be filed in writing or made to theBoard at the hearing - Secretary, Municipal Capital Borrowing Board,Marysville Place, P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick,E3B 5H1, TEL: 453-2154, FAX: 457-4991

If you require sign language interpretation or an assistive listeningdevice or FM system, please contact the Saint John Deaf & Hard ofHearing Services (TTY) (506) 634-8037.

NOTICE OF DISBARMENTPLEASE NOTE that, on October 2, 2002, a panel of the DisciplineCommittee of the Law Society ordered, with his consent, that RandallA. Hatfield of Saint John, NB, be disbarred from the Law Societypursuant to paragraph 60(1)(d) of the Law Society Act, 1996. The panelfound that Randall A. Hatfield misappropriated trust funds.Dated at Fredericton, New Brunswick, this 16th day of December 2002.

Marc L. Richard, Registrar of Complaints

Public notice is hereby given pursuant to subparagraph 285(2)(b)(iv) ofthe Credit Unions Act, Chapter C-32.2, that La Caisse Populaire deLameque Ltée. and La Caisse Populaire de St. Raphael-Sur-MerLimitee have amalgamated effective the 31st day of December 2002under the name “Caisse populaire des Iles Ltée”, and that the provi-sions of the Credit Unions Act have been complied with.

Suzanne Bonnell-Burley, Q.C., Superintendent of Credit Unions

_________________

Public notice is hereby given pursuant to subparagraph 285(2)(b)(iv) ofthe Credit Unions Act, Chapter C-32.2, that La Caisse Populaire de BasCaraquet Ltee and Caisse populaire de la Péninsule Ltée have amal-gamated effective the 31st day of December 2002 under the name“Caisse populaire de la Péninsule Ltée”, and that the provisions of theCredit Unions Act have been complied with.

Suzanne Bonnell-Burley, Q.C., Superintendent of Credit Unions

2:25 p.m. Hampton Transportation ServicesLoader $90,000Recreation and Cultural ServicesTruck ½ Ton $25,000

2:35 p.m. Cap-Pelé Environmental Health ServicesSewerage System $600,000

2:45 p.m. Plaster Rock Environmental Health ServicesLand Development $16,000

Notices

Department of Justice

Toute objection à ces demandes peut être présentée à la Commissionpar écrit ou de vive voix au moment de l’audience. Le secrétaire de laCommission des emprunts de capitaux par les municipalités, PlaceMarysville, C.P. 6000, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1;téléphone : 453-2154; télécopieur : 457-4991

Si vous avez besoin d’un service d’interprétation gestuelle ou d’un dis-positif technique pour malentendants (système FM), veuillez téléphonerau Saint John Deaf & Hard of Hearing Services au (506) 634-8037(ATS).

AVIS DE RADIATIONSACHEZ QUE le 2 octobre 2002, un sous-comité de discipline duBarreau ordonna avec son consentement la radiation du Barreau deRandall A. Hatfield de Saint-Jean (N.-B.), conformément à l’alinéa60(1)d) de la Loi de 1996 sur le Barreau. Le sous-comité a conclu queRandall A. Hatfield a détourné des fonds en fiducie.Fait à Fredericton, Nouveau-Brunswick le 16 décembre 2002.

Marc L. Richard, Registraire des plaintes

Sachez que, conformément au sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur lescaisses populaires, chapitre C-32.2, La Caisse Populaire de LamequeLtée. et La Caisse Populaire de St. Raphael-Sur-Mer Limitee ont fu-sionné pour devenir en date du 31 décembre 2002 « Caisse populairedes Iles Ltée » et que toutes les dispositions de la Loi sur les caisses po-pulaires ont été respectées.

La surintendante des caisses populaires, Suzanne Bonnell-Burley, c.r.

__________________

Sachez que, conformément au sous-alinéa 285(2)b)(iv) de la Loi sur lescaisses populaires, chapitre C-32.2, La Caisse Populaire de BasCaraquet Ltee et Caisse populaire de la Péninsule Ltée ont fusionnépour devenir en date du 31 décembre 2002 « Caisse populaire de laPéninsule Ltée » et que toutes les dispositions de la Loi sur les caissespopulaires ont été respectées.

La surintendante des caisses populaires, Suzanne Bonnell-Burley, c.r.

14 h 25 Hampton Services relatifs aux transportsChargeuse frontale 90 000 $Services récréatifs et culturelsCamion d’une demi-tonne 25 000 $

14 h 35 Cap-Pelé Services d’hygièneenvironnementaleRéseau d’égouts 600 000 $

14 h 45 Plaster Rock Services d’hygièneenvironnementaleAménagement d’un terrain 16 000 $

Avis

Ministère de la Justice

Page 17: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 81 Gazette royale — 22 janvier 2003

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

Farshad Yazdidoust and Leena Heydarynejad, Original Mortgagorsand Owners of the Equity of Redemption; Canadian Imperial Bank ofCommerce, Subsequent Mortgagee; and CIBC Mortgage Corporation,present Holder of the Mortgage. Sale under and by virtue of the provi-sions of a Mortgage registered in the York County Registry Office onOctober 26, 1992 under Official Number 358008. Freehold at79 Beaconsfield Street, Fredericton, County of York and Province ofNew Brunswick. Notice of Sale given by the above Holder of the Mort-gage. Sale on the 6th day of February, 2003 at the hour of 10:30 o’clockin the forenoon, at the Justice Building, 423 Queen Street, Fredericton,New Brunswick. See advertisements in The Daily Gleaner on January8, 15, 22 and 29, 2003. Notification to Farshad Yazdidoust and LeenaHeydarynejad, Canadian Imperial Bank of Commerce and all otherswhom it may concern.

CIBC Mortgage Corporation, By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for CIBC Mortgage Corporation

_________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.l(2)

Brian G. Aldridge and Kathy L. MacKay, Original Mortgagors andOwners of the Equity of Redemption; New Brunswick Electric PowerCommission, Judgment Creditor; Legal Aid New Brunswick, Judg-ment Creditor; and Firstline Trust Company, present Holder of theMortgage. Sale under and by virtue of the provisions of a Mortgageregistered in the York County Registry Office on October 22, 1993 un-der Official Number 368247. Freehold at 75 James Street, Fredericton,County of York and Province of New Brunswick. Notice of Sale givenby the above Holder of the Mortgage. Sale on the 6th day of February,2003 at the hour of 11:00 o’clock in the forenoon, at the Justice Build-ing, 423 Queen Street, Fredericton, New Brunswick. See advertise-ments in The Daily Gleaner on January 8, 15, 22 and 29, 2003. Notifi-cation to Brian G. Aldridge and Kathy L. MacKay, New BrunswickElectric Power Commission and Legal Aid New Brunswick and allothers whom it may concern.

Firstline Trust Company, By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for Firstline Trust Company

_________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.l(2)

William C. Trenholm and Shelley M. Trenholm, Original Mortgagorsand Owners of the Equity of Redemption; Her Majesty the Queen inRight of Canada c/o the Minister of National Revenue, As JudgmentCreditor; and CIBC Mortgage Corporation, present Holder of theMortgage. Sale under and by virtue of the provisions of a Mortgageregistered in the York County Registry Office on November 30, 1989under Official Number 327667. Freehold at 835 Sisson SettlementRoad, Burtts Corner, Parish of Bright, County of York and Province ofNew Brunswick. Notice of Sale given by the above Holder of the Mort-gage. Sale on the 6th day of February, 2003 at the hour of 10:00 o’clockin the forenoon, at the Justice Building, 423 Queen Street, Fredericton,New Brunswick. See advertisements in The Daily Gleaner on January8, 15, 22 and 29, 2003. Notification to William C. Trenholm, Shelley

Notices of Sale

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Farshad Yazdidoust et Leena Heydarynejad, débiteurs hypothécairesoriginaires et propriétaires du droit de rachat; la Banque CanadienneImpériale de Commerce, créancière hypothécaire postérieure; et la So-ciété d’hypothèques CIBC, titulaire actuelle de l’hypothèque. Venteeffectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque enregistré aubureau de l’enregistrement du comté d’York, le 26 octobre 1992, sousle numéro 358008. Biens en tenure libre situés au 79, rue Beaconsfield,Fredericton, comté d’York, province du Nouveau-Brunswick. Avis devente donné par la susdite titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieule 6 février 2003, à 10 h 30, au palais de justice, 423, rue Queen,Fredericton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans leséditions des 8, 15, 22 et 29 janvier 2003 du Daily Gleaner. Notificationfaite à Farshad Yazdidoust, à Leena Heydarynejad, à la Banque Cana-dienne Impériale de Commerce et à tout autre intéressé éventuel.

La Société d’hypothèques CIBC, par son avocat, Walter D. Vail, ducabinet Cox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Brian G. Aldridge et Kathy L. MacKay, débiteurs hypothécaires origi-naires et propriétaires du droit de rachat; la Commission d’énergieélectrique du Nouveau-Brunswick, créancière sur jugement; Aide juri-dique du Nouveau-Brunswick, créancière sur jugement; et FirstlineTrust Company, titulaire actuel de l’hypothèque. Vente effectuée envertu des dispositions de l’acte d’hypothèque enregistré au bureau del’enregistrement du comté d’York, le 22 octobre 1993, sous le numéro368247. Biens en tenure libre situés au 75, rue James, Fredericton,comté d’York, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donnépar le susdit titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu le 6 février2003, à 11 h, au palais de justice, 423, rue Queen, Fredericton(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des8, 15, 22 et 29 janvier 2003 du Daily Gleaner. Notification faiteà Brian G. Aldridge, à Kathy L. MacKay, à la Commission d’énergieélectrique du Nouveau-Brunswick, à Aide juridique duNouveau-Brunswick et à tout autre intéressé éventuel.

Firstline Trust Company, par son avocat, Walter D. Vail, du cabinetCox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

William C. Trenholm et Shelley M. Trenholm, débiteurs hypothécairesoriginaires et propriétaires du droit de rachat; Sa Majesté la Reine duchef du Canada, a/s du ministre du Revenu national, créancière sur ju-gement; et la Société d’hypothèques CIBC, titulaire actuelle de l’hypo-thèque. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothè-que enregistré au bureau de l’enregistrement du comté d’York, le30 novembre 1989, sous le numéro 327667. Biens en tenure libre situésau 835, chemin Sisson Settlement, Burtts Corner, paroisse de Bright,comté d’York, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donnépar la susdite titulaire de l’hypothèque. La vente aura lieu le 6 février2003, à 10 h, au palais de justice, 423, rue Queen, Fredericton(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des8, 15, 22 et 29 janvier 2003 du Daily Gleaner. Notification faite à

Avis de vente

Page 18: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 82 Gazette royale — 22 janvier 2003

M. Trenholm and Her Majesty the Queen in Right of Canada, c/o theMinister of National Revenue, and all others whom it may concern.

CIBC Mortgage Corporation, By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for CIBC Mortgage Corporation

_________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

Rodney Legresley and Donna Richardson, Original Mortgagors andOwners of the Equity of Redemption; and CIBC Mortgage Corpora-tion, present Holder of the Mortgage. Sale under and by virtue of theprovisions of a Mortgage registered in the Northumberland CountyRegistry Office on March 10, 1995 under Official Number 080775.Freehold at 405 North Barnaby Road, Barnaby, Parish of Nelson,County of Northumberland and Province of New Brunswick. Notice ofSale given by the above Holder of the Mortgage. Sale on the 5th day ofFebruary, 2003, at the hour of 10:00 o’clock in the forenoon, at theNorthumberland County Court House, 599 King George Highway,Miramichi, New Brunswick. See advertisements in the MiramichiLeader on January 7, 14, 21 and 28, 2003. Notification to RodneyLegresley and Donna Richardson, and all others whom it may concern.

CIBC Mortgage Corporation, By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for CIBC Mortgage Corporation

_________________

TODD W. TUPPER and KIMBERLY L. ROGERS, of 238 TarrtownRoad, in Monquart, in the County of Carleton and Province of NewBrunswick; RONALD W. JACKSON JR. of Johnville Road, in Kil-foil, County of Carleton, Province of New Brunswick; MADELINEJACKSON, of 57 Mechanic Street, in Bath, in the County of Carletonand Province of New Brunswick; and CITIFINANCIAL MORTGAGECORPORATION (before known as Avco Financial Services RealtyLimited), holder of the first of first Mortgage.And to all other whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 238 Tarrtown Road, inMonquart, in the County of Carleton and Province of New Brunswick.Notice of Sale is given by the holder of the said first mortgage.Sale to be held on February 6, 2003 at 11:00 o’clock in the morning atthe law offices of McCue Brewer located at 179 Broadway Street, inWoodstock, in the County of Carleton and Province of NewBrunswick. See advertisement in The Bugle.DATED at Edmundston, New Brunswick, this 2nd day of January,2003.

GARY J. McLAUGHLIN, McLaughlin Law Offices, Solicitors andagents for Citifinancial Mortgage Corporation

_________________

TO: Victor Kenneth Boucher, of 80 Tracy Road, Minto, NewBrunswick, Mortgagor;AND TO: New Brunswick Housing Corporation, a body corporatewith its head office in the City of Fredericton, County of York andProvince of New Brunswick, First Mortgagee;AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.NOTICE IS HEREBY GIVEN that by virtue of the provisions of theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19 as amended, and pursuant to thePower of Sale contained in a mortgage document dated the 1st day ofSeptember, 1994, made between Victor Kenneth Boucher, the Mort-gagor, and New Brunswick Housing Corporation, the Mortgagee andregistered in the Sunbury County Registry Office on the 9th day ofSeptember, 1994, as Official Number 80735, in Book 407, at Page 532,

William C. Trenholm, à Shelley M. Trenholm, à Sa Majesté la Reinedu chef du Canada (a/s du ministre du Revenu national), et à tout autreintéressé éventuel.

La Société d’hypothèques CIBC, par son avocat, Walter D. Vail, ducabinet Cox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Rodney Legresley et Donna Richardson, débiteurs hypothécaires ori-ginaires et propriétaires du droit de rachat; et la Société d’hypothèquesCIBC, titulaire actuelle de l’hypothèque. Vente effectuée en vertu desdispositions de l’acte d’hypothèque enregistré au bureau de l’enregis-trement du comté de Northumberland, le 10 mars 1995, sous le numéro080775. Biens en tenure libre situés au 405, chemin North Barnaby,Barnaby, paroisse de Nelson, comté de Northumberland, province duNouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titulaire del’hypothèque. La vente aura lieu le 5 février 2003, à 10 h, au palaisde justice du comté de Northumberland, 599, route King George,Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les édi-tions des 7, 14, 21 et 28 janvier 2003 du Miramichi Leader. Notifica-tion faite à Rodney Legresley, à Donna Richardson et à tout autre inté-ressé éventuel.

La Société d’hypothèques CIBC, par son avocat, Walter D. Vail, ducabinet Cox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

TODD W. TUPPER et KIMBERLY L. ROGERS, 238, cheminTarrtown, Monquart, comté de Carleton, province du Nouveau-Brunswick; RONALD W. JACKSON FILS, chemin Johnville,Kilfoil, comté de Carleton, province du Nouveau-Brunswick;MADELINE JACKSON, 57, rue Mechanic, Bath, comté de Carleton,province du Nouveau-Brunswick; et CITIFINANCIAL MORTGAGECORPORATION (connu antérieurement sous le nom de Avco Finan-cial Services Realty Limited), titulaire de la première hypothèque.Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 238, chemin Tarrtown, Monquart, comtéde Carleton, province du Nouveau-Brunswick.Avis de vente donné par le titulaire de ladite première hypothèque.La vente aura lieu le 6 février 2003, à 11 h, au cabinet McCue Brewer,situé au 179, rue Broadway, Woodstock, comté de Carleton, provincedu Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans The Bugle.

FAIT à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 2 janvier 2003.

GARY J. McLAUGHLIN, du cabinet juridique McLaughlin, avo-cats et représentants de Citifinancial Mortgage Corporation

__________________

DESTINATAIRE : Victor Kenneth Boucher, 80, chemin Tracy, Minto(Nouveau-Brunswick), débiteur hypothécaire;ET la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, une corporationayant son siège social dans la cité de Fredericton, comté d’York, pro-vince du Nouveau-Brunswick, première créancière hypothécaire; ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.SACHEZ qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les biens,L.R.N.-B. 1973, c.P-19, et conformément au pouvoir de vente contenudans l’acte d’hypothèque établi le 1er septembre 1994 entre VictorKenneth Boucher, débiteur hypothécaire, et la Société d’habitation duNouveau-Brunswick, créancière hypothécaire, et enregistré au bureaude l’enregistrement du comté de Sunbury le 9 septembre 1994, sous lenuméro 80735, à la page 352 du registre 407, sera vendu à l’encan, à

Page 19: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 83 Gazette royale — 22 janvier 2003

there will be sold at Public Auction at 80 Tracy Road, Minto, NewBrunswick, on the 4th day of February, 2003 at the hour of 1:00 o’clockin the afternoon, all that freehold and land and premises lying and be-ing at 80 Tracy Road, Minto, New Brunswick, more particularly de-scribed in Schedule “A” hereto, unless the mortgage principal and in-terest together with the costs of the sale to date are sooner paid.If a satisfactory offer is not received, the lands may be withdrawn fromthe said sale and later sold privately with or without further notice be-ing given.This Notice of Sale is given by the New Brunswick Housing Corpora-tion, Mortgagee.For further particulars apply to Nicholas D. DiCarlo, of 340King Street, Suite 2, Fredericton, New Brunswick, E3B 1E3,(506) 450-8494.Dated at the City of Fredericton, New Brunswick this 11th day ofDecember, 2002.

Nicholas D. DiCarlo, 340 King Street, Suite 2, Fredericton, NBE3B 1E3, (506) 450-8494, Solicitor for New Brunswick HousingCorporation

SCHEDULE “A”ALL that certain, piece, parcel or tract of land and premises lying, be-ing and situate in the Parish of Northfield, in the County of Sunbury, inthe Province of New Brunswick being LOT 90-2 shown on theTRACY ROAD SUBDIVISION SUBDIVISION PLAN prepared byHitchman Surveys (1987) Ltd. (Ronald N. Robinson N.B.L.S.) DatedOctober 18, 1990 and approved by Ernest King, Development Officer,Village of Minto, on November 14, 1990 and filed in the SunburyCounty Registry Office on the 19th day of November, 1990 as PlanNumber 91-90.

_________________

To: Gail Albert, of 1285 Cahill Drive East, in the City of Ottawa andProvince of Ontario, Mortgagor;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 20 Des Patriotes Street,in the Town of Caraquet, in the County of Gloucester and Province ofNew Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the firstmortgage.Sale on the 20th day of January, 2003, at 11:00 a.m., at the Court Housein Bathurst, 254 St. Patrick Street, Bathurst, New Brunswick. See ad-vertisement in The Northern Light.

Anderson, McWilliam, LeBlanc & MacDonald, Solicitors for themortgagee, the Royal Bank of Canada

_________________

To: Phillip Dale Tinker, of 41 Schooner Cove Road, Wilsons Beach, inthe County of Charlotte and Province of New Brunswick, Mortgagor;

And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 41 Schooner Cove Road,Wilsons Beach, in the County of Charlotte and Province of NewBrunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the firstmortgage.Sale on the 12th day of February, 2003, at 11:30 a.m., at the Town Hallin St. Stephen, 34 Milltown Boulevard, St. Stephen, New Brunswick.See advertisement in The Saint Croix Courier.

Anderson, McWilliam, LeBlanc & MacDonald, Solicitors for themortgagee, the Royal Bank of Canada

_________________

moins que le prêt hypothécaire, soit le principal et les intérêts, ainsi queles coûts engendrés jusqu’à présent pour la vente, ne soient payés plustôt, le 4 février 2003, à 13 h, au 80, chemin Tracy, Minto (Nouveau-Brunswick), le terrain en tenure libre, y compris ses bâtiments, situé au80, chemin Tracy, Minto (Nouveau-Brunswick), et plus précisémentdésigné à l’annexe « A » ci-jointe.À défaut de recevoir une offre d’achat suffisante, le terrain pourra êtreretiré de la vente et vendu privément par la suite, avec ou sans autreavis.Le présent avis de vente est donné par la Société d’habitation duNouveau-Brunswick, créancière hypothécaire.Pour plus de renseignements, communiquer avec Me NicholasDiCarlo, 340, rue King, pièce 2, Fredericton (Nouveau-Brunswick)E3B 1E3; téléphone : (506) 450-8494.Fait dans la cité de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le11 décembre 2002.

Nicholas DiCarlo, 340, rue King, pièce 2, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1E3; téléphone : (506) 450-8494, avocat de la Sociétéd’habitation du Nouveau-Brunswick

ANNEXE « A »TOUTE la parcelle de terre, y compris ses bâtiments, située dans laparoisse de Northfield, comté de Sunbury, province du Nouveau-Brunswick, et figurant comme le LOT 90-2 sur le plan de lotissementintitulé « TRACY ROAD SUBDIVISION PLAN », dressé le 18 octo-bre 1990 par Hitchman Surveys (1987) Ltd. (Ronald N. Robinson,AGNB) et approuvé le 14 novembre 1990 par Ernest King, agentd’aménagement, village de Minto. Ledit plan ayant été enregistré aubureau de l’enregistrement du comté de Sunbury le 19 novembre 1990,sous le numéro 91-90.

__________________

Destinataire : Gail Albert, 1285, promenade Cahill Est, cité d’Ottawa,province de l’Ontario, débitrice hypothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 20, rue des Patriotes, ville de Caraquet,comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de lapremière hypothèque.La vente aura lieu le 20 janvier 2003, à 11 h, au palais de justice deBathurst, 254, rue St. Patrick, Bathurst (Nouveau-Brunswick). Voirl’annonce publiée dans The Northern Light.

Anderson, McWilliam, LeBlanc & MacDonald, avocats de la créan-cière hypothécaire, la Banque Royale du Canada

__________________

Destinataire : Phillip Dale Tinker, 41, chemin Schooner Cove, WilsonsBeach, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick, débiteurhypothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 41, chemin Schooner Cove, WilsonsBeach, comté de Charlotte, province du Nouveau-Brunswick.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de lapremière hypothèque.La vente aura lieu le 12 février 2003, à 11 h 30, à l’hôtel de villede St. Stephen, 34, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans The Saint Croix Courier.

Anderson, McWilliam, LeBlanc & MacDonald, avocats de la créan-cière hypothécaire, la Banque Royale du Canada

__________________

Page 20: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 84 Gazette royale — 22 janvier 2003

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.l(2)

Gerard Chiasson and Monique Chiasson, Original Mortgagors andOwners of the Equity of Redemption; Household Realty CorporationLimited, Subsequent Mortgagee; La Caisse Populaire De St. Sauveur,Judgment Creditor; La Caisse Populaire De Shippagan Limitée, Judg-ment Creditor; and CIBC Mortgages Inc., present Holder of the Mort-gage. Sale under and by virtue of the provisions of a Mortgage regis-tered in the Gloucester County Registry Office on August 27, 1997under Official Number 292681. Freehold at 270 Haggerty Street, NorthTetagouche, Parish of Bathurst, County of Gloucester and Province ofNew Brunswick. Notice of Sale given by the above Holder of the Mort-gage. Sale on the 6th day of February, 2003 at the hour of 10:30 o’clockin the forenoon, at the Gloucester County Court House, 254 St. PatrickStreet, Bathurst, Gloucester County, New Brunswick. See advertise-ments in The Northern Light on January 8, 15, 22 and 29, 2003. Noti-fication to Gerard Chiasson, Monique Chiasson, Household RealtyCorporation Limited, La Caisse Populaire De St. Sauveur, La CaissePopulaire De Shippagan Limitée and all others whom it may concern.

CIBC Mortgages Inc., By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for CIBC Mortgages Inc.

_________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.l(2)

Raymond B. Green, Original Mortgagor and Owner of the Equity ofRedemption; Citifinancial Canada East Corporation, SubsequentMortgagee; and CIBC Mortgage Corporation, present Holder of theMortgage. Sale under and by virtue of the provisions of a Mortgageregistered in the Saint John County Registry Office on April 1, 1992under Official Number 377119. Freehold at 107 Adelaide Street, SaintJohn, County of Saint John and Province of New Brunswick. Notice ofSale given by the above Holder of the Mortgage. Sale on the 6th day ofFebruary, 2003, at the hour of 10:30 o’clock in the forenoon, at theSaint John County Court House, 22 Sydney Street, Saint John, NewBrunswick. See advertisements in the Telegraph-Journal on January 8,15, 22 and 29, 2003. Notification to Raymond B. Green, CitifinancialCanada East Corporation and all others whom it may concern.

CIBC Mortgage Corporation, By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for CIBC Mortgages Inc.

_________________

Sale of Lands Publication Act R.S.N.B. 1973, c.S-2, s.l(2)

Joseph Laurie Doucet and Marie Thérèsa Doucet, Original Mortgagorsand Owners of the Equity of Redemption; and CIBC Mortgages Inc.,present Holder of the Mortgage. Sale under and by virtue of the provi-sions of a Mortgage registered in the Gloucester County Registry Of-fice on September 10, 2001 under Official Number 12806734. Free-hold at 1119 Principale Street, Beresford, Parish of Beresford, Countyof Gloucester and Province of New Brunswick. Notice of Sale given bythe above Holder of the Mortgage. Sale on the 6th day of February,2003 at the hour of 10:00 o’clock in the forenoon, at the GloucesterCounty Court House, 254 St. Patrick Street, Bathurst, GloucesterCounty, New Brunswick. See advertisements in The Northern Light onJanuary 8, 15, 22 and 29, 2003. Notification to Joseph Laurie Doucetand Marie Thérèsa Doucet and all others whom it may concern.

CIBC Mortgages Inc., By: Cox Hanson O’Reilly Matheson,Per: Walter D. Vail, Solicitor for CIBC Mortgages Inc.

_________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Gerard Chiasson et Monique Chiasson, débiteurs hypothécaires origi-naires et propriétaires du droit de rachat; Household Realty Corpora-tion Limited, créancier hypothécaire postérieur; La Caisse PopulaireDe St. Sauveur, créancière sur jugement; La Caisse Populaire DeShippagan Limitée, créancière sur jugement; et Hypothèques CIBCInc, titulaire actuelle de l’hypothèque. Vente effectuée en vertu des dis-positions de l’acte d’hypothèque enregistré au bureau de l’enregistre-ment du comté de Gloucester le 27 août 1997, sous le numéro 292681.Biens en tenure libre situés au 270, rue Haggerty, North Tetagouche,paroisse de Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titulaire de l’hypothè-que. La vente aura lieu le 6 février 2003, à 10 h 30, au palais de justicedu comté de Gloucester, 254, rue St. Patrick, Bathurst, comté deGloucester, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiéedans les éditions des 8, 15, 22 et 29 janvier 2003 du Northern Light.Notification faite à Gerard Chiasson, à Monique Chiasson, à House-hold Realty Corporation Limited, à La Caisse Populaire De St.Sauveur, à La Caisse Populaire De Shippagan Limitée et à tout autreintéressé éventuel.

Hypothèques CIBC Inc., par son avocat, Walter D. Vail, du cabinetCox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Raymond B. Green, débiteur hypothécaire originaire et propriétaire dudroit de rachat; Citifinancial Canada East Corporation, créancier hypo-thécaire postérieur; et la Société d’hypothèques CIBC, titulaire actuellede l’hypothèque. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acted’hypothèque enregistré au bureau de l’enregistrement du comté deSaint John, le 1er avril 1992, sous le numéro 377119. Biens en tenurelibre situés au 107, rue Adelaide, Saint John, comté de Saint John, pro-vince du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titu-laire de l’hypothèque. La vente aura lieu le 6 février 2003, à 10 h 30,au palais de justice du comté de Saint John, 22, rue Sydney, Saint John(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des8, 15, 22 et 29 janvier 2003 du Telegraph-Journal. Notification faite àRaymond B. Green, à Citifinancial Canada East Corporation et à toutautre intéressé éventuel.

La Société d’hypothèques CIBC, par son avocat, Walter D. Vail, ducabinet Cox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, art.1(2)

Joseph Laurie Doucet et Marie Thérèsa Doucet, débiteurs hypothécai-res originaires et propriétaires du droit de rachat; et Hypothèques CIBCInc, titulaire actuelle de l’hypothèque. Vente effectuée en vertu des dis-positions de l’acte d’hypothèque enregistré au bureau de l’enregistre-ment du comté de Gloucester, le 10 septembre 2001, sous le numéro12806734. Biens en tenure libre situés au 1119, rue Principale,Beresford, paroisse de Beresford, comté de Gloucester, province duNouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susdite titulaire del’hypothèque. La vente aura lieu le 6 février 2003, à 10 h, au palais dejustice du comté de Gloucester, 254, rue St. Patrick, Bathurst, comté deGloucester, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiéedans les éditions des 8, 15, 22 et 29 janvier 2003 du Northern Light.Notification faite à Joseph Laurie Doucet, à Marie Thérèsa Doucet et àtout autre intéressé éventuel.

Hypothèques CIBC Inc., par son avocat, Walter D. Vail, du cabinetCox Hanson O’Reilly Matheson

__________________

Page 21: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 85 Gazette royale — 22 janvier 2003

To: Darren L. Snodgrass, of 24 Starkey Avenue, in the Town ofRothesay, in the County of Kings and Province of New Brunswick andDeborah A. Snodgrass, of 24 Starkey Avenue, in the Town of Kingsand Province of New Brunswick, Mortgagor; And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 24 Starkey Avenue, in theTown of Rothesay, in the County of Kings and Province of NewBrunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of the firstmortgage.Sale on the 26th day of February, 2003 at 10:30 a.m., at the KingsCounty Registry Office, 1-648 Main Street, Hampton, NewBrunswick. See advertisement in the Telegraph-Journal.

Anderson, McWilliam, LeBlanc & MacDonald, Solicitors for themortgagee, the Royal Bank of Canada

_________________

Michel J. Noel and Linda B. Noel, spouse of Michel J. Noel, Ownersof the Equity of Redemption and Original Mortgagor; and CIBC Mort-gages Inc., Mortgagee and holder of the Mortgage. Sale conducted un-der the terms of the Mortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973,c.P-19, s.44 as amended. Freehold property situate at 2295 Route 115,Irishtown, in the Parish of Moncton, in the County of Westmorland andProvince of New Brunswick. Notice of sale given by the above holderof the Mortgage. Sale in the Main Lobby, Assumption Place, 770 MainStreet, in the City of Moncton, in the County of Westmorland and Prov-ince of New Brunswick on Tuesday the 18th day of February, A.D.2003 at the hour of 11:00 in the forenoon, local time. See advertisementin the New Brunswick Telegraph-Journal in the issues of January 15,22, 29 and February 5, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the Mortgagee, CIBC Mortgages Inc.

_________________

Ola J. Ouellette and Norma M. Ouellette, spouse of Ola J. Ouellette,Original Mortgagor; KPMG Inc., Trustee in Bankruptcy of the Estatesof Ola J. Ouellette and Norma M. Ouellette, Owner of the Equity ofRedemption; Household Realty Corporation Limited, Second Mort-gagee; and CIBC Mortgage Corporation, First Mortgagee and holderof the First Mortgage. Sale conducted under the terms of the FirstMortgage and the Property Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 asamended. Freehold property situate at 48 Nicholle Road, in the City ofSaint John, in the County of Saint John and Province of NewBrunswick. Notice of sale given by the above holder of the First Mort-gage. Sale at the County Court House, 22 Sydney Street, in the City ofSaint John, in the County of Saint John and Province of NewBrunswick on Monday the 17th day of February, A.D. 2003 at the hourof 10:00 in the forenoon, local time. See advertisement in the NewBrunswick Telegraph-Journal in the issues of January 15, 22, 29 andFebruary 5, 2003.

Gorman Nason, Solicitors for the First Mortgagee, CIBC MortgageCorporation

Destinataires : Darren L. Snodgrass, 24, avenue Starkey, ville deRothesay, comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick, etDeborah A. Snodgrass 24, avenue Starkey, ville de Rothesay, comté deKings, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 24, avenue Starkey, ville de Rothesay,comté de Kings, province du Nouveau-Brunswick.

Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulaire de lapremière hypothèque.La vente aura lieu le 26 février 2003, à 10 h 30, au bureau de l’enregis-trement du comté de Kings, 1-648, rue Main, Hampton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans le Telegraph-Journal.

Anderson, McWilliam, LeBlanc & MacDonald, avocats de la créan-cière hypothécaire, la Banque Royale du Canada

__________________

Michel J. Noel et Linda B. Noel, conjointe de Michel J. Noel, proprié-taires du droit de rachat et débiteurs hypothécaires originaires; et Hy-pothèques CIBC Inc., créancière hypothécaire et titulaire de l’hypothè-que. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèqueet de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19, art.44.Biens en tenure libre situés au 2295, route 115, Irishtown, paroisse deMoncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick.Avis de vente donné par la susdite titulaire de l’hypothèque. La venteaura lieu le mardi 18 février 2003, à 11 h, heure locale, dans le foyerprincipal de Place-de-l’Assomption, 770, rue Main, cité de Moncton,comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’an-nonce publiée dans les éditions des 15, 22 et 29 janvier et du5 février 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la créancière hypothécaire, HypothèquesCIBC Inc.

__________________

Ola J. Ouellette et Norma M. Ouellette, conjointe d’Ola J. Ouellette,débiteurs hypothécaires originaires; KPMG Inc., syndic de faillite desbiens d’Ola J. Ouellette et Norma M. Ouellette, propriétaires du droitde rachat; Household Realty Corporation Limited, deuxième créancierhypothécaire; et la Société d’hypothèques CIBC, première créancièrehypothécaire et titulaire de la première hypothèque. Vente effectuée envertu des dispositions du premier acte d’hypothèque et de celles de laLoi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c. P-19, art. 44. Biens en tenure libresitués au 48, chemin Nicholle, cité de Saint John, comté de Saint John,province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la susditetitulaire de la première hypothèque. La vente aura lieu le lundi17 février 2003, à 10 h, heure locale, au palais de justice du comté, 22,rue Sydney, cité de Saint John, comté de Saint John, province duNouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans les éditions des15, 22 et 29 janvier et du 5 février 2003 du New Brunswick Telegraph-Journal.

Gorman Nason, avocats de la première créancière hypothécaire, laSociété d’hypothèques CIBC

Page 22: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the

The Royal Gazette — January 22, 2003 86 Gazette royale — 22 janvier 2003

The Royal Gazette is published every Wednesday under the authorityof the Queen’s Printer Act. Documents must be received by TheRoyal Gazette editor, in the Queen’s Printer Office, no later thannoon, at least nine days prior to Wednesday’s publication. Each doc-ument must be separate from the covering letter. Signatures on docu-ments must be immediately followed by the printed name. TheQueen’s Printer may refuse to publish a document if any part of it isillegible, and may delay publication of any document for administra-tive reasons.

Prepayment is required for the publication of all documents. Stan-dard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refunds will beissued for cancellations.

Annual subscriptions are $80.00 plus postage and expire December31st. If your subscription is not for a full calendar year, please contactthe Office of the Queen’s Printer to obtain a prorated amount.Single copies are $2.00. (Taxes are not included.)

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: (506) 453-2520 Fax: (506) 457-7899E-mail: [email protected]

NoticesCost perInsertion

Citation $ 20Examination for License as Embalmer $ 20Examination for Registration of Nursing Assistants $ 15Intention to Surrender Charter $ 15List of Names (cost per name) $ 10Notice under Board of Commissioners of Public Utilities $ 30Notice to Creditors $ 15Notice of Legislation $ 15Notice under Liquor Control Act $ 15Notice of Motion $ 20Notice under Political Process Financing Act $ 15Notice of Reinstatement $ 15Notice of Sale including Mortgage Sale and Sheriff Sale

Short Form $ 15Long Form (includes detailed property description) $ 60

Notice of Suspension $ 15Notice under Winding-up Act $ 15Order $ 20Order for Substituted Service $ 20Quieting of Titles — Public Notice (Form 70B)

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″ $ 75Writ of Summons $ 20Affidavits of Publication $ 5

Notice to Advertisers

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à laLoi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doiventparvenir à l’éditrice de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeurde la Reine, à midi, au moins neuf jours avant le mercredi de publi-cation. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms dessignataires doivent suivre immédiatement la signature. L’Imprimeurde la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisibleet retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives.

Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voiciles tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit Mas-terCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l’ordre du minis-tre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en casd’annulation.

Le tarif d’abonnement annuel est de 80 $, plus les frais postaux, etl’abonnement prend fin le 31 décembre. Si vous ne désirez pas unabonnement pour une année civile complète, veuillez communiqueravec le bureau de l’Imprimeur de la Reine afin d’obtenir un prixproportionnel. Le prix le numéro est de 2 $. (Taxes en sus)

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

Tél. : (506) 453-2520 Téléc. : (506) 457-7899Courriel : [email protected]

AvisCoût par parution

Citation 20 $Examen en vue d’obtenir un certificat d’embaumeur 20 $Examen d’inscription des infirmiers(ères) auxiliaires 15 $Avis d’intention d’abandonner sa charte 15 $Liste de noms (coût le nom) 10 $Avis – Commission des entreprises de service public 30 $Avis aux créanciers 15 $Avis de présentation d’un projet de loi 15 $Avis en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools 15 $Avis de motion 20 $Avis en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique 15 $Avis de réinstallation 15 $Avis de vente, y compris une vente de biens hypothéqués et

une vente par exécution forcéeFormule courte 15 $Formule longue (y compris la désignation) 60 $

Avis de suspension 15 $Avis en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies 15 $Ordonnance 20 $Ordonnance de signification substitutive 20 $Validation des titres de propriété (Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po 75 $Bref d’assignation 20 $Affidavits de publication 5 $

Avis aux annonceurs

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés

Page 23: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the
Page 24: The Royal Gazette royale - New Brunswick · The Royal Gazette — January 22, 2003 66 Gazette royale — 22 janvier 2003 DECEMBER 19, 2002 2002-453 Under paragraph 6(1)(b) of the