53

30 Annual Report 2015 2016 - Moneycontrol.com › bse_annualreports › 5117280316.pdf30 th Annual Report 2015-2016 K. Z. LEASING & FINANCE LTD . 1st Floor, Deshna Chamber, Ashram

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 30th

    Annual Report

    2015-2016

    K. Z. LEASING & FINANCE LTD.

    1st Floor, Deshna Chamber, Ashram Road, Usmanpura,

    Ahmedabad – 380014.

  • 30th Annual Report: 2015-16 1 | P a g e   

    SAFE HARBOUR STATEMENT 

    In  this  Annual  Report  we  have  disclosed  forward‐looking  information  [within  the meaning of  various  laws]  to enable  investors  to  comprehend our prospects and  take informed investment decisions. This report and other statements–written and oral‐that we  periodically  make,  contain  forward‐looking  statements  that  set  out  anticipated results based on  the Management’s plans and assumptions. We have  tried wherever possible  to  identify  such  statements  by  using words  such  as  anticipate’,  ‘estimate’, ‘expects’,  ‘projects’,  ‘intends’,  ‘plans’,  ‘believes’  and  words  of  similar  substance  in connection with any discussion of future performance. 

    We cannot guarantee that these forward‐looking statements will be realized, although we believe we have been prudent in assumptions. The achievement of results is subject to  risks,  uncertainties  and  even  inaccurate  assumptions.  Should  known  or  unknown risks or uncertainties materialize or  should underlying  assumptions prove  inaccurate, actual  results  could  vary materially  from  those  anticipated,  estimated  or  projected. Readers should bear this in mind. 

    We  undertake  no  obligation  to  publicly  update  any  forward‐looking  statements, whether as a result of new information, future events or otherwise 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 30th Annual Report: 2015-16 2 | P a g e   

    Important Communication to Shareholders “Green Initiative in the Corporate Governance” 

    Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken a “Green Initiative in the Corporate Governance” by allowing paperless compliances by  the Companies and has  issued a circular No.17/2011 on April 21, 2011 stating  that  the service of document to shareholders by a Company can be made through electronic mode. 

    Keeping in view the underlying theme and to support this green initiative of Government in the right spirit, members who holds shares  in electronic mode and who have not registered their email addresses, so far, are requested to register their email address and changes therein from time to time, with the Depository through their concerned Depository  Participants. Members who  hold  shares  in  physical  form  are  requested  to  fill  the  below mentioned prescribed form, giving their consent to receive the Notices calling general meetings, audited financial statements, auditors’  report, directors’  report,  explanatory  statement or  any other  communication  in  electronic mode,  and register the said form with Link Intime India Private Limited. 

    Please note that you will be entitled to be furnished, free of cost, with a physical copy of the notice, balance sheet and all other documents required by  law to be attached thereto  including the profit &  loss account and auditors’ report etc., upon receipt of a requisition from you, any time, as a member of the Company. We are sure you would appreciate the “Green Initiative” taken by MCA and your Company’s desire to participate in such initiatives. 

    Email Address Registration Form 

    (For members who holds shares in Physical Forms) K Z LEASING AND FINANCE LIMITED 

    Registered Office: 1st Floor, Deshana Chamber, B/h. Kadwa pattidar Wadi, Ashram Road, Ahmedabad‐380014  

    Ledger Folio No._____________________                   No. of Share(s) held: ________________________ 

    NAME OF THE SHAREHOLDER / JOINT HOLDER : _________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________ 

    Email Address: i)____________________________  ii)_______________________________________                                                     

    Contact No. (R) __________________________M)__________________________________________ 

    I hereby  give my  / our  consent  to  receive  the Notices  calling  general meetings,  audited  financial  statements,  auditors’ report, directors’ report, explanatory statement and all other documents required by law to be attached thereto or any other communication in electronic mode at my/our above mentioned email ID. 

    Signed this ____________________day of _____________________________ , 2016.  Note : 1)  Members are requested to send their duly completed form as above to the Registrar and Transfer Agent (RTA) namely 

    Link Intime India Pvt. Ltd. Unit No. 303, 3rd Floor, Shoppers Plaza V, Opp. Municipal Market, Behind Shoppers Plaza II, Off C. G. Road, Ahmedabad‐380009 Tele: 07926465179   Tele fax : 079‐26465179 

    2)  Members are also requested to inform about any change in their email ID immediately to RTA.      

     

     

     

     

  • 30th Annual Report: 2015-16 3 | P a g e   

    -

    Scrip Code:  BSE 511728 

                          

    FORM A 

    Format of covering letter of the Annual Audit Report to be filed with the stock exchanges 

    1.  Name of the Company  K Z LEASING AND FINANCE LIMITED 2. Annual Financial statements for the year 

    ended 31st March, 2016

    3. Type of Audit observation  Un‐qualified

    4. Frequency of observation  Not Applicable

    5. To be signed by      

    • Managing Director‐      Pravinkumar Keshavlal Patel   

    • Director‐     Ankit Pravinkumar Patel    

       • Audit Committee Chairman‐     

       

      Gandalal Ambalal Patel   

    Statutory Auditor of the Company —    

          

      J. M. Patel & Bros. 

            

  • 30th Annual Report: 2015-16 4 | P a g e   

    Corporate Information  

                             Founder : Late Keshavlal Zaverchand Patel                 _________________________________________________________________ 

                             Board of Directors             Shri Pravinkumar Keshavlal Patel   Chairman & Managing director 

                                       Shri Rameshbhai Narandas Patel      Independent Director                                    Shri Keshavlal Kashiramdas Patel     Independent Director                                    Shri Gandalal Ambalal Patel              Independent Director                                    Shri Ankit Pravinkumar Patel            Director & CFO                                    Shri Kantibhai Joytiram Patel           Independent Director                                    Smt. Chaitali Bharatbhai Patel         Woman Director                                    _______________________________________________________        

                             Audit Committee                                    Shri Gandalal Ambalal Patel, Chairman                                    Shri Kantilal Joytiram Patel, Member                                    Shri Pravinbhai Keshavlal Patel, Member                                    Smt. Chaitaliben B Patel, Member                                    _______________________________________________________  

                                       Shareholders / Investor’s Grievance Committee  Shri Rameshbhai Narandas Patel, Chairman   Shri Gandalal Ambalal Patel, Member  

                                       Shri Pravinbhai Keshavlal Patel, Member                                     Smt. Chaitaliben B Patel, Member                                   _______________________________________________________ 

                             Corporate Social Responsibility Committee  Shri Rameshbhai Narandas Patel, Chairman  Shri Kantilal Joytiram Patel, Member  Shri Gandalal Ambalal Patel, Member _______________________________________________________ 

    Nomination & Remuneration Committee Shri Kantilal Joytiram Patel, Chairman  

                                      Shri Rameshbhai Narandas Patel, Member  Shri Gandalal Ambalal Patel, Member    COMPANY SECRETARY – Mrs. Hinal Anish Shah  

        

  • 30th Annual Report: 2015-16 5 | P a g e   

        

    Registered Office                                                Contents                      Page No. 1st Floor, Deshana Chamber,                             Notice to the Shareholders                                 06 B/h Kadwa Pattidar Wadi,                                 Directors’ Report                                                   10 Ashram Road,                                                      Secretarial Audit Report                                       21 Ahmedabad‐380014                                          Management Discussion & Analysis                                                                                             Report                                                                      23 

          Corporate Governance Report                            25 Tel.: 079-27542298                                        Auditor’s Certificate on Corporate  Fax: 079-27543200                                      Governance                                                             30 

                                                                       Certificate on Compliance with condition  CIN: L65910GJ1986PLC008864                        of Corporate Governance                                     30 Email Id: [email protected]                 Independent Auditors’ Report                             31    Statutory Auditor                                        Balance Sheet                                                         35 J. M. Patel & Bros.                                                     Profit and Loss Account                                              36 

    Internal Auditor                                      Notes to Accounts                                                  37 Marmik G. Shah & Associates                           Cash Flow Statement                                             44 

    Secretarial Auditor                  Proxy Form                                                              48                         Mr. Amit Patel                               Attendance Slip                                                       50 

                                                                                                                  Bankers                                                      

    The Navnirman Co‐Op. Bank Ltd.                    UCO Bank                                                             HDFC Bank                  Shree Kadi Nagrik Sahakari Bank Ltd.                                          

     Registrars and Transfer Agents            Link Intime India Private Limited.                               (Formerly, Intime Spectrum Registry limited)    C ‐ 13, Pannalal Silk Mills Compound,                 L. B. S. Marg, Bhandup (W)                                   Mumbai – 400078.                                                  Phone; 022‐2594 6970/78                                               

  • 30th Annual Report: 2015-16 6 | P a g e   

    Notice to the Shareholders 

    NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of K Z Leasing And Finance Limited will be held on Wednesday, 14th September, 2016 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company at 1st Floor, Deshana Chamber, B/h. Kadva Patidar Wadi, Ashram Road, Ahmedabad ‐380014. to transact the following business:  

    ORDINARY BUSINESS:  

    1.   To receive, consider and adopt the Audited Statement of Profit and Loss Account ended on 31st March, 2016 and the Balance Sheet as at that date together with the Cash flow Statement, Report of Board of Directors and the Auditors’ Report thereon and to pass with or without modification the following resolution as Ordinary Resolution: 

     

          "RESOLVED THAT the Directors' Report to the Shareholders, Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2016 , and the Balance Sheet as at that date, the Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2016, together with the Auditors' Report thereon be and are hereby received and adopted."  

    2.  To appoint a director in place of Mr. Ankit Pravinkumar Patel (holding DIN 02901371), Director who retires by rotation and being eligible, offers herself for reappointment and to pass with or without modification the following resolution as Ordinary Resolution: 

     

          "RESOLVED that Mr. Ankit Pravinkumar Patel, who retires by rotation and being eligible offers herself for re‐appointment, be and is hereby re‐appointed as Director of the Company." 

     

    3.   To  consider  the Ratification of M/s  J. M. Patel & Brothers, Chartered Accountants  as  the  Statutory  auditors of  the Company and to pass, with or without modification, the following Resolution as Ordinary Resolution: 

     

     “RESOLVED THAT pursuant to Sections 139, 142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and 

    the  Companies  (Audit  and Auditors)  Rules,  2014,  the  Company  hereby  ratifies  the  appointment  of M/s  J. M.  Patel & 

    Brothers, Chartered Accountants, (FRN‐ 107707W) from whom Certificate pursuant to section 139 of the Companies Act, 

    2013 has been received, as Auditors of the Company to hold office from the conclusion of this Annual General Meeting 

    (AGM) till the conclusion of the next AGM of the Company to be held in the year 2017.”  

    REGISTERED OFFICE:                      ON BEHALF OF THE BOARD 1st Floor, Deshna Chamber,                                                                          FOR, K Z LEASING AND FINANCE LTD.                 B/h, Kadva Patidar Wadi,                                              Ashram Road,            Ahmedabad –380014.                                                                     Pravinkumar K Patel                    Ankit P. Patel 

    (Chairman and Managing Director)          (Director) Date: 30/07/2016           (DIN: 00841628)                     (DIN: 02901371)                                                    NOTES:  

    1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT ONE OR MORE PROXIES TO  ATTEND  AND,  ON  A  POLL,  VOTE  INSTEAD  OF  HIMSELF,  SUCH  PROXY  NEED  NOT  BE  A MEMBER  OF  THE COMPANY. A person can act as proxy on behalf of members not exceeding 50 [fifty] and holding in aggregate not more than ten (10) per cent of the total share capital of the Company. In case proxies proposed to be appointed by a Member holding more than ten(10) percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such proxy shall not act as a proxy for any such other person or shareholder. The instrument of Proxy in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed  and  signed,  not  less  than  48  hours  before  the  commencement  of  the meeting  i.e.by  11.00  a.m.  on Monday, 12th September, 2016. A Proxy form is sent herewith. Proxy form submitted on behalf of the Companies, Societies, etc. must be supported by an appropriate resolution / authority, as applicable. 

     

    2. The  relevant  details  as  stipulated  under  Clause  49  of  the  Listing  Agreement  with  the  Stock  Exchange(s)  and SEBI(Listing  Obligations  and  Disclosure  Requirements)  Regulations,  2015,  in  respect  of  Directors  seeking  re‐appointment as directors Item Nos. 2 above, is also annexed hereto. 

    3. Relevant  documents  referred  to  in  the  accompanying  Notice  are  open  for  inspection  by  the members  at  the registered office of the company on all working days, except Sundays, between 11 a.m. and 1 p.m. up to the date of meeting. 

    4. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed for a period of Nine (9) days from Tuesday, 6th day of September, 2016 to Wednesday, 14th day of September, 2016 (both days inclusive). 

     

  • 30th Annual Report: 2015-16 7 | P a g e   

    5. Members are requested to contact Registrar and Transfer Agent (RTA) namely Link  Intime  India Pvt. Ltd. Unit No. 303, 3rd Floor, Shoppers Plaza V, Opp. Municipal Market, Behind Shoppers Plaza  II, Off C. G. Road, Ahmedabad‐380009  for recording any change of address, bank mandate, ECS or nominations, and  for redressal of complaints contact the Compliance Officer at the Registered Office of the Company. 

     

    6.  The  equity  shares  of  the  company  are  available  for  dematerialization,  as  the  company  has  entered  into  an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services Limited (CDSL). Those  shareholders  who  wish  to  hold  the  company’s  share  in  electronic  form may  approach  their  depository participants.  

     

    7. Section 72 of the Companies Act, 2013, extends the nomination facility to individual shareholders of the Company. Therefore,  the  shareholders holding  share certificates  in physical  form and willing  to avail  this  facility may make nomination  in Form SH 13, which may be sent on request. However,  in case of demat holdings, the shareholders should approach to their respective depository participants for making nominations. 

     

    8. Members who hold shares in dematerialized form are requested to bring their client ID and DP ID numbers for easy identification of attendance at the meeting. 

            

    9. Members  are  requested  to  bring  their  copies  of  Annual  Report  at  the  meeting.  Shareholders  seeking  any information with regard to account are requested to write to the Company early so as to enable the Management to keep the information ready. 

     

    10. Members  /  Proxies  are  requested  to bring with  them  the  attendance  slip duly  filled  in  and hand  it over  at  the entrance.  

    11.  Members, who have multiple accounts in identical names or joint names in same order are requested to intimate M/s. Link Intime (India) Pvt. Ltd., the Ledger Folios of such accounts to enable the Company to consolidate all such share holdings into one account. 

     

    12.  Pursuant to Section 101 and Section 136 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made there under, Companies can serve Annual Reports and other communications through electronic mode to those Members who have  registered  their  e‐mail  address  either with  the  Company  or with  the Depository. Members who  have  not registered their e‐mail addresses so far are requested to register their e‐mail address so that they can receive the Annual Report and other communication from the Company electronically. Members holding shares in demat form are requested to register their e‐mail address with their Depository Participant(s) only. Members of the Company, who  have  registered  their  e‐mail  address,  are  entitled  to  receive  such  communication  in  physical  form  upon request. 

     

    13. Voting through electronic means:  

    Pursuant  to  Section  108  of  the  Companies Act,  2013,  read with  the  relevant  Rules  of  the Act,  the  Company  is pleased  to  provide  the  facility  to Members  to  exercise  their  right  to  vote  by  electronic means.  The Members desiring to vote through electronic mode may refer to the detailed procedure on e‐voting given hereinafter: 

     

    The instructions for shareholders voting electronically are as under:  

    (i) The voting period begins on 10th September, 2016 at 9.00 a.m. and ends on 13th September, 2016 at 5.00 p.m. During this period shareholders’ of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut‐off date  (record date) of 6th September, 2016, may cast their vote electronically. The e‐voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. 

    (ii) The shareholders should log on to the e‐voting website www.evotingindia.com (iii) Click on Shareholders. (iv) Now Enter your User ID  

     

    a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,  b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,  c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company. 

    (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login. (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting 

    of any company, then your existing password is to be used.  (vii) If you are a first time user follow the steps given below:   For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

    PAN  Enter  your  10  digit  alpha‐numeric  *PAN  issued  by  Income  Tax  Department  (Applicable  for  both  demat 

  • 30th Annual Report: 2015-16 8 | P a g e   

    shareholders as well as physical shareholders)• Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested 

    to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN field. 

    DOB  Enter  the Date of Birth as  recorded  in your demat account or  in  the  company  records  for  the  said demat account or folio in dd/mm/yyyy format. 

    Dividend Bank Details 

    Enter the Dividend Bank Details as recorded  in your demat account or  in the company records for the said demat account or folio. 

    • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv). 

     

    (viii) After entering these details appropriately, click on “SUBMIT” tab. (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members 

    holding shares  in demat  form will now reach  ‘Password Creation’ menu wherein  they are required  to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts  for e‐voting  through CDSL platform.  It  is  strongly  recommended not  to  share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. 

    (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e‐voting on the resolutions contained in this Notice. 

    (xi) Click on the EVSN for the K Z Leasing And Finance Limited on which you choose to vote. (xii) On the voting page, you will see “RESOLUTION DESCRIPTION” and against the same the option “YES/NO” for voting. 

    Select  the option YES or NO as desired. The option YES  implies  that you assent  to  the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution. 

    (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details. (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If 

    you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote. 

    (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote. (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page. (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User  ID and the  image verification code 

    and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system. (xviii) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians 

    • Non‐Individual  shareholders  (i.e.  other  than  Individuals, HUF, NRI  etc.)  and  Custodian  are  required  to  log  on  to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate. 

    • A  scanned  copy  of  the  Registration  Form  bearing  the  stamp  and  sign  of  the  entity  should  be  emailed  to [email protected]

    • After  receiving  the  login  details  a  compliance  user  should  be  created  using  the  admin  login  and  password.  The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on. 

    • The  list  of  accounts  should  be mailed  to  [email protected]  and  on  approval  of  the  accounts  they would be able to cast their vote.  

    • A  scanned  copy  of  the  Board  Resolution  and  Power  of  Attorney  (POA) which  they  have  issued  in  favour  of  the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same. 

    (xix) In case you have any queries or  issues regarding e‐voting, you may refer the Frequently Asked Questions  (“FAQs”) and  e‐voting  manual  available  at  www.evotingindia.com,  under  help  section  or  write  an  email  to [email protected].  

    i) Mr. Amit K. Patel, Practicing Company Secretary (C.O.P – 15068) has been appointed for as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting and remote e‐voting process in a fair and transparent manner. 

    ii) The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e‐voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer’s report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith. 

    iii) The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the BSE Limited, Mumbai. 

  • 30th Annual Report: 2015-16 9 | P a g e   

    Explanatory Statements pursuant to section 102[1] of the Companies Act, 2013. 

    The following statements set out all material facts relating to Special Businesses mentioned in the accompanying Notice.  

    Profile of Retiring Directors: Item No. 2  Name   Ankit Pravinkumar PatelQualification  Bcom. , M.com.Experience  Over 10 years of wide ranging experience in Finance AreaOther Directorship   K Z Cotspin LimitedChairman / Member of the Committees of the Board of the other companies on which he is a director 

    None

    No. of shares held in the company   5551 Equity shares of Rs. 10 each Disclosure of the relationships  Ankit P. Patel is the son of Mr. Pravinbhai K Patel, Chairman and 

    Managing Director and husband of Mrs. Chaitali A. Patel, Director of the Company. 

     

     REGISTERED OFFICE: 1st Floor, Deshna Chamber,                                                                  BY ORDER OF THE BOARD B/h, Kadva Patidar Wadi,                                                                      FOR, K Z LEASING AND FINANCE LTD. Ashram Road,  Ahmedabad –380014.           

      Pravinkumar K Patel                    Ankit P Patel 

    Date: 30/07/2016                  (Chairman and Managing Director)            (Director)                                        (DIN: 00841628)                     (DIN: 02901371)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • 30th Annual Report: 2015-16 10 | P a g e   

    Directors’ Report 

    Your Directors are pleased  to present  the Company’s 30th Annual Report and  the audited accounts  for  the year ended 31st March, 2016. 

    FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR 2015‐16:                                                                                 (Amount in Rs.) 

    PARTICULARS 2015-16 2014-15

    Income From Operation 17,28,448.00 10,61,294.00 Other Income 57,08,587.00 71,83,207.27 Total Income 74,37,035.00 82,44,501.27 Less: Operational Expenses 39,07,035.00 36,54,205.80 Profit before Interest, Depreciation 35,30,000.00 45,90,295.47 Less :Depreciation and Finance Cost 1,11,371.00 32,624.00 Profit/ Loss Before Tax 11,89,437.00 31,40,586.52 Less: Tax expenses 0.00 7,13,881.50 Profit/ Loss After Tax 11,89,437.00 24,26,705.02  

    PERFORMANCE REVIEW: During the year under review, the Company has generated total revenue of Rs. 74,37,035 as against Rs 82,44,501.27 of the previous financial year. The net profit for the year under review has been Rs. 11,89,437 as against Rs. 24,26,705.02 during the previous financial year. Your Directors are continuously  looking for the new avenues for future growth of the Company and expect more growth in future period.  

    A detailed analysis of the financial results is given in the Management Discussion and Analysis Report, which forms part of this report.  

    DIVIDEND & APPROPRIATIONS: In order  to conserve  the resources,  in the year 2015‐16, the Directors do not recommend any dividend  for the year under review.  

    BOARD OF DIRECTORS:  

    1. Mr. Ankit Pravinkumar Patel (DIN: 02901371), Director of the Company retires by rotation and, being eligible, offers himself for re‐appointment. 

    2. Independent Directors: The  Independent Directors have  submitted  their declarations of  independence,  as  required pursuant  to              the provisions of section 149(7) of the Act, stating that they meet the criteria of independence. 

     

    SUBSIDIARY, JOINT VENTURE AND ASSOCIATE COMPANY: 

    The company has no subsidiary company, Joint Venture Company or Associate Company.  

    PUBLIC DEPOSIT: During  the  year  under  review  your  Company  has  not  accepted  deposit  form  public  as  envisaged  by  Chapter  V  of  the Companies Act, 2013 and as per rules and regulations framed by Reserve Bank of India for Non Banking Finance Companies.   

    CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS: There is no Change in the nature of the business of the Company done during the year.  

    CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS / OUTGO: 

    As required by the provisons of Section 134(3)(m) of the Companies Act,2013, read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 the relevant data pertaining to conservation of energy, technology absorption are not applicable and hence, not given. The Company has no Foreign Exchange earnings and outgo during the year under review. 

    PARTICULARS OF EMPLOYEES: 

    There are no employees drawing the remuneration  in excess of  limits prescribed under Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.  

    MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS,  IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAS OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT: 

  • 30th Annual Report: 2015-16 11 | P a g e   

    No such material changes and commitments, affecting the financial position of the company have occurred and hence no comments required. 

    SIGNIFICANT & MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS: During the year no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company’s operations in future. 

    CHANGES IN SHARES CAPITAL: The Company has not made any changes in the share capital of the company during the year under review. 

    INSURANCE:  All the assets of the company are adequately insured and the Company has developed proper system for taking insurance on all its assets in order to mitigate the risk.  

    AUDITORS:  

    I. STATUTORY AUDITORS & AUDITORS’ REPORT: In view of  the  internal process of  re‐alignment at  the Statutory Auditors’  firm, M/s.  J. M. Patel & Bros.,  (FRN: 107707W), Chartered Accountants, Ahmedabad has been re‐appointed as the Statutory Auditors of the Company.  

    The Statutory Auditors of the Company, M/s. J. M. Patel & Bros., (FRN: 107707W), Chartered Accountants, Ahmedabad hold office until the conclusion of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received a letter from M/s. J. M. Patel & Bros.  to  the  effect  that  their  appointment, will be  as per  the  requirements  laid down under  Section  139  and 141 of  the Companies  Act,  2013  read with  Rule  4  of  the  Companies  (Audit  and  Auditors)  Rules,  2014.  The  Statutory  Auditors  have expressed  its  intention  to hold office  from  the  conclusion of  the 29th Annual General Meeting of  the Company, up  to  the conclusion of the 34th Annual General Meeting pursuant to the provisions of the said sections, subject to ratification of the appointment at every Annual General Meeting.  

    Accordingly, a resolution  is being submitted to the Members for the ratification of appointment of M/s. J. M. Patel & Bros., Chartered Accountants and to allow the Board to fix their remuneration for the current year.   II. Auditors’ Report: The Auditors’ Report does not contain any adverse remark(s) and hence no comments required. The notes of accounts referred to in the auditors’ report are self explanatory and therefore do not require any further comments.  

    III. INTERNAL CONTORL SYSTEM Pursuant to the provisions of section 138 of the Companies Act and rules made there under, the company has proper system of Internal Control and it has also appointed internal auditor to look after the matters of internal control.   

    IV. SECRETARIAL AUDITOR AND SECRETARIAL AUDIT REPORT: Pursuant  to  the provisions of  section 204 of  the Act  and  The Companies  [Appointment  and Remuneration of Managerial Personnel] Rules, 2014, the Company has appointed Mr. Amit K. Patel, Practicing Company Secretary to undertake Secretarial Audit for the financial year ended on 31st March, 2016. Secretarial Audit Report is attached to this report as Form MR‐3. The Board has duly reviewed the Secretarial Auditor’s Report and the observations and comments, appearing  in the report are self‐explanatory and do not call for any further explanation / clarification by the Board of Directors as provided under section 134 of the Act.  

    CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): The  Board  of  your  Company  has  constituted  a  CSR  Committee.  As  on  31 March,  2016,  the  Committee  comprises  three Directors. CSR Committee has  recommended  to  the Board, a CSR Policy,  indicating  the activities  to be undertaken by  the Company, which is approved by the Board and carried to the Annual Report.   

    The  company’s  net  profit,  turnover  and  net worth  are  outside  the  criteria  of  Section  135  of  the  Companies  Act,  2013, therefore, it is not required to spend any amount under CSR Activity.  

    ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY: The Company is a Non banking finance company hence it is not in such activity which affects the environment adversely, however, it accords the highest priority to Environment, Health and Safety. The management is constantly reviewing the safety standards of the employees and the management believes in the concept of sustainable development.  

    MANAGING THE RISKS OF FRAUD, CORRUPTION AND UNETHICAL BUSINESS PRACTICES: i. Vigil Mechanism / Whistle Blower Policy: The  Company  has  established  vigil mechanism  and  framed whistle  blower  policy  for  Directors  and  employees  to  report concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of Company’s Code of Conduct or Ethics Policy.  

     

    ii. Business Conduct Policy:  

  • 30th Annual Report: 2015-16 12 | P a g e   

    The Company has framed “Business Conduct Policy”. Every employee is required to review and sign the policy at the time of  joining and an undertaking shall be given  for adherence  to  the Policy. The objective of  the Policy  is  to conduct  the business in an honest, transparent and in an ethical manner. The policy provides for anti‐bribery and avoidance of other corruption practices by the employees of the Company. 

     

    AUDIT COMMITTEE:        The Audit Committee comprises of 4 members namely, Chairman Shri Gandalal Ambalal Patel, Shri Kantilal  Joytiram Patel, Smt. Chaitaliben B. Patel and Shri Pravinbhai Keshavlal Patel. The audit committee duly met at regular  intervals during  the mentioned  financial year and  in  respect of which meetings proper notices were given and  the proceedings were properly recorded and signed in the Minutes Book maintained for the purpose. The Meetings of Audit committee was held four times on  during  the  financial  year  and  further  details  of  attendance  of  directors  in  the  Committee meeting  are mentioned  in Corporate Governance Report. 

     

    The Committee periodically discussed the Financial Reporting process, reviewed the Financial Statements, and discussed the quality  of  the  applied  accounting  principles  and  significant  judgment  that  affected  the  Company’s  Financial  Statements. Before presenting the audited accounts to the members of the Board, the Audit Committee recommended the appointment of the statutory auditors, subject to the Board’s approval. The audit Committee reviewed with adequacy of  internal control systems with the management, statutory and internal auditors.  

    TRANSFER OF AMOUNTS TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND: The  company  has  not  declared  dividend  in  any  of  the  previous  seven  years  and  hence  there  is  no  fund  lying  as unclaimed/unpaid dividend and hence it is not required to transfer to IEPF Account.  

    ACCOUNTING STANDARDS AND FINANCIAL REPORTING: 

    The Company incorporates the accounting standards as and when issued by the Institute of chartered Accountants of India. The Company Complied with the Stock Exchange and  legal requirement concerning the Financial Statements at the time of preparing them for the Annual Report.   

    CORPORATE GOVERNANCE: Your Company  follows  the principles of effective Corporate Governance. The Company has  complied with  the mandatory provisions  of  Corporate Governance  as  prescribed  in  the  erstwhile  Clause  49  of  the  Listing  Agreement  and  SEBI  (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 executed with the Stock Exchange(s).   

    A  separate  section  on  Corporate Governance  is  included  in  the  Annual  Report  and  Certificate  from  Company’s  Auditors confirming the compliance with the code of Corporate Governance as enumerated in prescribed in the erstwhile Clause 49 of the Listing Agreement and SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 is annexed hereto.  

    MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT: Management’s Discussion  and Analysis  Report  for  the  year  under  review,  as  stipulated  under  erstwhile  Clause  49  of  the Listing Agreement  and  SEBI  (Listing Obligations  and Disclosures  Requirement)  Regulations,  2015  executed with  the  Stock Exchange, is presented in a separate section forming part of the Annual Report.  

    DEMATERIALISATION OF EQUITY SHARES: As per direction of the SEBI and Bombay Stock Exchange Limited, the shares of the Company are under compulsory demat form. The Company has established connectivity with both  the Depositories  i.e. National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited and the demat activation number allotted to the Company is ISIN: INE 006C01015. Presently shares are held in electronic and physical mode (81.84% of shares in demat, 18.16% in physical mode).  

    LISTING: The equity shares of the company are listed in the Bombay Stock Exchange Limited which has the connectivity in most of the cities across the country.  

    NUMBER OF MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS: The Board of Directors duly met at  regular  intervals during  the mentioned  financial year and  in  respect of which meetings proper notices were given and the proceedings were properly recorded and signed  in the Minutes Book maintained for the purpose.  The  details  regarding  the meetings  of  board  of  directors  and  the  attendance  of  the  directors  in  the  same  is mentioned in Corporate Governance Report. NUMBER OF MEETINGS OF THE AUDIT COMMITTEE: The Audit Committee duly met at regular intervals during the mentioned financial year and in respect of which meetings proper notices were given and the proceedings were properly recorded and signed in the Minutes Book maintained for the purpose. The details regarding the meetings of Audit Committee and the attendance of the directors in the same is mentioned in Corporate Governance Report.   

  • 30th Annual Report: 2015-16 13 | P a g e   

    NUMBER OF MEETINGS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE: The Nomination  and  Remuneration  Committee  duly met  at  regular  intervals  during  the mentioned  financial  year  and  in respect of which meetings proper notices were given and the proceedings were properly recorded and signed in the Minutes Book maintained for the purpose. The details regarding the meetings of Nomination and Remuneration Committee and the attendance of the directors in the same is mentioned in Corporate Governance Report.  

    DISCLOSURE UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (Prevention, Prohibition and Redressal Act, 2013): The Company has in place an Anti Sexual Harassment Policy in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. Internal Complaints Committee (ICC) has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under this policy.  

    DIRECTORS’ RESPONSIBILITY STATEMENT: In terms of section 134[3] [c] of the Act, your Directors state that: 

    a) in the preparation of the annual financial statements for the year ended on 31st  March, 2016, applicable accounting standards  read with  requirements  set  out  under  schedule  III  of  the  Act,  have  been  followed  along with  proper explanation relating to material departures, if any, 

     

    b) such accounting policies have been selected and applied consistently and  judgments and estimates made  that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at 31st March, 2016 and of the profit of the company for the year ended on that date, 

     

    c) proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records  in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for prevention and detection of fraud and other irregularities, 

     

    d) the annual financial statements are prepared on a going concern basis,  

    e) proper  internal  financial  controls  are  in  place  and  that  the  financial  controls  are  adequate  and  are  operating effectively and 

     

    f) the  systems  to  ensure  compliance with  the  provisions  of  all  applicable  laws  are  in  place  and  are  adequate  and operating effectively. 

    PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES AND INVESTMENTS UNDER SECTION 186: During the period under report, the Company has not provided guarantee to any person or Body Corporate. It has given current Loans to some parties in its ordinary course of business and as it is an NBFC company, it is outside the purview of Section 186 of the Companies Act, 2013. 

    EXTRACT OF ANNUAL RETURN: Pursuant to Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 read with rules 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the extract of annual return is annexed herewith as MGT‐9 and forming part of the report. 

    RISK MANAGEMENT POLICY: The Company has developed and implemented a risk management policy which identifies major risks which may threaten the existence of the Company. The same has also been adopted by your Board and is also subject to its review from time to time. Risk mitigation process and measures have been also formulated and clearly spelled out in the said policy.  

    PARTICULARS OF CONTRACTS AND ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES: 

    The Particulars of contracts or arrangements with related parties are given in the prescribed Form AOC‐2 appended herewith as Annexure‐A. ACKNOWLEDGMENT: 

    Your  Directors  wish  to  place  on  record  their  sincere  appreciation  to  the  financial  institutions,  Company’s  bankers  and customers, vendors and investors for their continued support during the year.  

    Your Directors are also pleased  to  record  their appreciation  for  the dedication and contribution made by employees at all levels who through their competence and hard work have enabled your Company achieve good performance year after year and look forward to their support in future as well.   REGISTERED OFFICE:               BY ORDER OF THE BOARD 1st Floor, Deshna Chamber,                                         FOR, K Z LEASING AND FINANCE LTD.                                    B/h, Kadva Patidar Wadi,                                              Ashram Road,  Ahmedabad –380014.             Pravinkumar K Patel                     Ankit P Patel Date: 30‐07‐2016                                             (Chairman and Managing Director)          (Director)                                            

              (DIN: 00841628)           (DIN: 02901371) 

  • 30th Annual Report: 2015-16 14 | P a g e   

    ANNEXURE‐A FORM NO. AOC ‐2 

    (Pursuant to clause (h) of sub‐section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014. 

    Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub  section  (1)  of  section  188  of  the  Companies Act,  2013  including  certain  arms  length  transaction  under  third  proviso thereto. 

     

    1. Details of contracts or arrangements or transactions not at Arm’s length Basic: SL. No.  Particulars Details

    a)  Name (s) of the related party & nature of relationship NILb)  Nature of contracts/arrangements/transaction NILc)  Duration of the contracts/arrangements/ transaction NILd)  Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any  NILe)  Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions’ NILf)  Date of approval by the Board  NILg)  Amount paid as advances, if any  NILh)  Date on which the special resolution was passed in General meeting as required under first proviso 

    to section 188 NIL

     

    2.    Details of contracts or arrangements or transactions at Arm’s length Basic:  

    Sr.  No. 

    Name(s) of the related party and nature of relationship 

    Nature of Contracts /arrangements /Transactions 

    Salient terms of the contracts of arrangements or transactions including value, if any: 

    Duration of Contracts/arrangements/ Transactions 

    Date(s) of the approval by the Board and Audit Committee, if any 

    Amount paid as advances, If any 

    1  Mr. Pravinbhai Keshavlal  Patel 

    Managing director 

    Salary of Rs. 20,000 per month & allowance  of Rs. 1600 per month aggregating to Rs. 2,59,200 

    From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    2  Mr. Ankit Pravinkumar Patel 

    Director  1) Salary of Rs. 29,166.67 per month & allowance  of Rs. 1600 per month aggregating to Rs. 3,69,200. 2) Interest paid of Rs. 1,78,062 

    From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    3  Mrs. Chaitali Bharatbhai Patel 

    Director  Salary of Rs. 29,166.67 per month & allowance  of Rs. 1600 per month aggregating to Rs. 3,69,200 

    From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    4  Mr. Gandalal Ambalal Patel 

    Director  allowance  of Rs. 1600 per month aggregating to Rs. 19,200 

    From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    5  Mr. Kantibhai Joytiram Patel 

    Director  allowance  of Rs. 1600 per month aggregating to Rs. 19,200 

    From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    6  Mr.Amratlal Kashiram patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4473 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    7  Mrs. Anandiben Vishnubhai Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4793 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    8  Mr.Babulal K. Patel  Relative  Interest paid of Rs.11651 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil9  Mrs. Bhagwatiben 

    Gandlal Patel Relative  Interest paid of Rs. 95352 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    10  Mr. Bharatbhai B.Patel  Relative  Interest paid of Rs. 3822 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil11  Dhyani Hardik Patel  Relative  Interest paid of Rs. 3640 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil12  Mr.Dipak Gandalal Patel  Relative  Interest paid of Rs. 4913 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil13  Mr. Gandalal Ambalal 

    Patel Director  Interest paid of Rs. 3430 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    14  Mr. Hardik P.Patel  Relative  Interest paid of Rs. 1,38,279 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil15  J.K.Patel & Company  Relative  Interest paid of Rs. 4812 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil16   Mrs. Kailashben 

    Kirtikumar Patel Relative  Interest paid of Rs. 4581 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    17  Mrs. Kailashben Pravinbhai Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4,75,898 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    18  Mr. Kantilal Joitaram Patel 

    Director  Interest paid of Rs. 11,828 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    19  Mrs. Kapilaben B. Patel  Relative  Interest paid of Rs. 3,844 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    20  Mrs. Kena Hardik Patel  Relative  Interest paid of Rs. 4,18,938 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

  • 30th Annual Report: 2015-16 15 | P a g e   

    21  Mr. Kirtikumar Prahladbhai Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4478 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    22  Mrs. Lataben N. Patel  Relative  Interest paid of Rs. 78,015 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    23  Mr. Manilal Joitaram Patel  

    Relative  Interest paid of Rs. 3059 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    24  Mrs. Manjulaben Kantilal Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 2640 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    25  Mr. Manubhai Joitaram Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 3611 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    26  Mr. Mihir Patel  Relative  Interest paid of Rs. 3822 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil27  Mrs. Mina R.Patel & 

    Menaben R. Patel  Relative  Interest paid of Rs. 990 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    28  Mrs. Mitaben M. Patel  & Menaben R. Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 990 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    29  Mrs. Mitaben Mukeshbhai Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4201 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    30  Mr. Mohanbhai Joitaram Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 3697 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    31  Mrs. Parulben G Patel  Relative  Interest paid of Rs. 1716 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil32  Mrs. Sejal Kantilal Patel  Relative  Interest paid of Rs. 314 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil33  Mrs. Sejal Gandalal Patel  Relative  Interest paid of Rs. 4535 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil34  Mrs. Shardaben Manilal 

    Patel Relative  Interest paid of Rs. 3576 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    35  Mrs. Sushilaben Manubhai Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4812 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    36  Mrs. Vidhyaben Sitaram Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4719 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    37  Mr.Vishnubhai Prabhudas Patel 

    Relative  Interest paid of Rs. 4337 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil

    38  Keshavlal Z Patel HUF  Relative  Interest paid of Rs. 1,67,023 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015 Nil39  Pravinkumar & Company  Director  Interest  paid of Rs. 11,386 From 1st April, 2015 to 31st  March, 2016  27/05/2015  Nil

     FORM NO. MGT 9 

    EXTRACT OF ANNUAL RETURN As on financial year ended on 31.03.2016 

    Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014. 

     

    I  REGISTRATION & OTHER DETAILS: i  CIN  L65910GJ1986PLC008864 ii  Registration Date                                                  07/08/1986iii  Name of the Company  K Z LEASING AND FINANCE LIMITED 

    iv Category/Sub‐category of the Company 

    Non‐Government Company 

    v Address of the Registered office  & contact details 

    1ST FLOOR DESHANA CHAMBER, B/H KADWAPATTIDAR WADI, ASHRAM ROAD  AHMEDABAD‐380001 

    vi  Whether listed company  YES

    vii Name , Address & contact details of the Registrar  & Transfer Agent, if any. 

    Link Intime India Private Limited, C‐13, Pannalal Silk mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (W), Mumbai‐400078 Phone No.  022‐25946970/78           

     

    II  PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated 

    SL No 

    Name & Description of  main products/services 

    NIC Code of the  Product /service 

    % to total turnover  of the company 

    1  FINANCE AND FINANCIAL SERVICES  65  100  

    III  PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES Sl No  Name & Address of the Company 

    CIN/ GLN 

    HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATE 

    % OF  SHARES HELD 

    APPLICABLE SECTION 

    1             2                

       

  • 30th Annual Report: 2015-16 16 | P a g e   

    IV  SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share capital Break up as % to total Equity) Category of Shareholders  No. of Shares held at the beginning of the 

    year No. of Shares held at the end of the year  % change during 

    the year 

       Demat  Physical  Total % of Total Shares 

    Demat Physical Total  % of Total Shares 

    A. Promoters       (1) Indian       a) Individual/HUF  639444  0  639444 21.03  701253 0 701253  23.06  61809 2.03b) Central Govt.or State Govt.  0  0  0 ‐    0 0 0  ‐    0 ‐c) Bodies Corporates  0  0  0      ‐    0 0 0        ‐    0 ‐d) Bank/FI  0  0  0      ‐    0 0 0        ‐    0 ‐‐e) Any other  0  0  0            ‐    0 0 0              ‐    0 ‐SUB TOTAL:(A) (1)  639444  0  639444 21.03  701253 0 701253  23.06  61809 2.03(2) Foreign       a) NRI‐ Individuals  0  0  0            ‐    0 0 0              ‐    0 ‐b) Other Individuals  0  0  0            ‐    0 0 0              ‐    0 ‐c) Bodies Corp.  0  0  0            ‐    0 0 0              ‐    0 ‐d) Banks/FI  0  0  0            ‐    0 0 0              ‐    0 ‐e) Any other…  0  0  0            ‐    0 0 0              ‐    0 ‐SUB TOTAL (A) (2)  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐Total Shareholding of Promoter  (A)= (A)(1)+(A)(2) 

    639444  0  639444     21.03  701253  0  701253  23.0  61809  2.03 

    B. PUBLIC SHAREHOLDING       (1) Institutions       a) Mutual Funds  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐b) Banks/FI  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐C) Central Govt.  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐d) State Govt.  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐e) Venture Capital Fund  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐f) Insurance Companies  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐g) FIIS  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐h) Foreign Venture Capital          

    Funds 0  0  0         ‐    0  0  0  ‐  0  ‐ 

    i) Others (specify)  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐SUB TOTAL (B)(1):  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐(2) Non Institutions       a) Bodies corporate       i) Indian  216044  6100  222144 7.30  158164 6100 164264  5.40  ‐57880 ‐1.90ii) Overseas  0  0  0            ‐    0 0 0  ‐  0 ‐

    b) Individuals       i) Individual shareholders 

    holding  nominal share capital upto Rs.1 lakhs 

    630498  550910  1181408  38.85  568505  546110  1114615  36.65  ‐66793  ‐2.20 

    ii) Individualshareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakhs 

    945360  0  945360  31.09  966290  0  966290  31.77  20930  0.69 

    Hindu Undivided Family  14765  0  14765  0.49  84693  0  84693  2.79  69928  2.30 Clearing Member  33392  0  33392     1.10  9445 0 9445  0.31  ‐23947 ‐0.79

    NRI and Foreign Co.  4687  0  4687      0.15  640 0 640  0.02  ‐4047 ‐0.13SUB TOTAL (B)(2):  1844746  557010  2401756  78.97  1787737 552210 2339947  76.94  ‐61809 ‐2.03Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2) 

    1844746  557010  2401756  78.97  1787737  552210  2339947  76.94  ‐61809  ‐2.03 

    C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs 

    0  0  0              ‐    0  0  0  ‐  0  ‐ 

    Grand Total (A+B+C)  2484190  557010  3041200 100.00  2488990 552210 3041200  100.00  0 0            

                

  • 30th Annual Report: 2015-16 17 | P a g e   

     (ii) 

     SHARE HOLDING OF PROMOTERS 

    Sl No. 

    Shareholders Name 

    Shareholding at the  beginning of the year 

    Shareholding at the  end of the year  % 

    change in share holding during the year 

    No of shares 

    % of total shares  of the 

    company 

    % of shares pledged 

    encumbered to total shares 

    No of shares 

    % of total shares  of the 

    company 

    % of shares pledged 

     encumbered to total shares 

    1  Menaben Keshavlal Family Trust  1,50,000  4.93  0  1,50,000  4.93  0  ‐ 2  Kailashben Pravinbhai Patel  1,50,000  4.93  0  1,50,000  4.93  0  ‐ 3  Gandalal Ambalal Patel  91,100  3.00  0  91,100  3.00  0  ‐ 

    4 Keshavlal Zaverchand Patel Family Trust  88,400  2.91  0  88,400  2.91  0  ‐ 

    5  Hardik Pravinbhai Patel  39,100  1.29  0  39,100  1.29  0  ‐ 6  Pravinbhai Keshavlal Patel  15,100  0.50  0  15,100  0.50  0  ‐ 7  Patel Rameshbhai Narandas  2,500  0.08  0  2,500  0.08  0  ‐ 8  Patel Kena Hardik  94,744  3.12  0  1,50,002  4.93  0  1.19 9  Chaitali Ankitbhai Patel  8500  0.28  0  9,500  0.31  0  0.03 10.  Ankit Pravinkumar Patel  0  0  0  5551  0.18  0  0.18 

    Total  6,39,444  21.03  0  7,01,253  23.06  0  2.03  

    (iii)  CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING ( SPECIFY IF THERE IS NO CHANGE) 

    Sl. No. 

       Share holding at the beginning of the Year 

    Cumulative Share holding during the year 

    No. of Shares 

    % of total shares of the company 

    No of shares 

    % of total shares of the company 

       At the beginning of the year  6,39,444  21.04 

      

    Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc) 

     AS PER ANNEXURE‐B      

       At the end of the year  7,01,253  23.06  

    (iv )  Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs) 

    Sl. No 

    For Each of the Top 10 Shareholders 

    Share holding at the beginning of the Year 

    Cumulative Share holding during the year 

    No. of Shares 

    % of total shares of the company 

    No of shares 

    % of total shares of the company 

       At the beginning of the year  608216  20.00 

      

    Date wise increase/decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc) 

    AS PER ANNEXURE ‐C   

     

       At the end of the year (or on the date of separation, if separated during the year) 712945  23.44  

    (v)  Shareholding of Directors & KMP 

    Sl. No 

    For Each of the Directors & KMP 

    Share holding at the beginning of the Year 

    Cumulative Share holding during the year 

    No. of Shares 

    % of total shares of the company 

    No of shares 

    % of total shares of the company 

       At the beginning of the year  117200  3.86   117200  3.86 

      

    Date wise increase/decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc) 

    AS PER ANNEXURE‐D       

       At the end of the year  123751  4.07  123751  4.07      

  • `  

    I

    TCARNI

    V

    AS

        

      

        

        

     

    BSNo

            

               

    CSN

        

    V.  IN

    ndebtness at thi) Principal Amii) Interest dueiii) Interest acc

    Total (i+ii+iii) Change in IndebAdditions Reduction Net Change ndebtedness ati) Principal Amii) Interest dueiii) Interest acc

    Total (i+ii+iii) 

    VI.   REMUNERA

    A  RemuneSl.No 

    1 (a) SalarTax. 196(b) Value(c ) ProfAct, 196

    2  Stock op3  Sweat E4  Commis

    as % of pothers : 

    5  Others, Total (ACeiling a

    B. RemunerationSl. No  Particulars1  Independe

    (a) Fee f(b) Com(c ) Othe

    Total (1) 2  Other Non

    (a) Fee f(b) Com(c ) Othe

    Total (2) Total (B)=(

    C. REMUNERATISl. No 1 

    (a) Salary(b) Value

    NDEBTEDNESS 

    Indebtedn

      he beginning of tmount e but not paid crued but not du

    btedness during 

    t the end of the mount e but not paid crued but not du

    ATION OF DIRECT

    eration to Mana

    ry as per provisio61. e of perquisites its in lieu of sala61 ption quity ssion profit ALLOWANCE please specify 

    A) as per the Act 

    n  to other direc

    s of Remuneratient Directors for attending bomission ers, please speci

    n Executive Direfor attending bomission ers, please speci

    (1+2) 

    ION TO KEY MA

    y as per provisioe of perquisites u

    ness of the Comp

    the financial yea

    ue 

    the financial ye

    financial year 

    ue 

    TORS AND KEY M

    aging Director, WParticular

    Gross salaryons contained in

    u/s 17(2) of theary under section

    ctors 

    ion 

    ard committee 

    fy (Allowance) 

    ctors ard committee 

    fy 

    NAGERIAL PERS

    ParticularGross

    ns contained in u/s 17(2) of the I

    pany including i

    ar 

    ear 

    MANAGERIAL P

    Whole time dirers of Remunerat

    y n section 17(1) o

     Income tax Act,n 17(3) of the In

    meetings 

    meetings 

    SONNEL OTHER T

    rs of Remunerats Salary section 17(1) ofIncome Tax Act,

    3

    nterest outstanSecured Loa

     excluding dep  

    4225

    4225  

    (3288

      38,

    38,

    ERSONNEL 

    ctor or Managetion  

    of the Income 

    , 1961 come Tax 

      Gandab

    THAN MD/MAN

    tion 

    f the Income Tax 1961 

    30th Annual

    ding/accrued bans posits 

      944.43 

    0 0 

    944.43   

    0 873.43) 

    0   

    97,071 0 0 

    97,071 

    r: 

    Pravinkumar Patel (M

    2,40,000 

    0 0 0 0 

    19,200 0 

    2,59,200 1,30,838.07 

    bhai A Patel 0 0 

    19200 19200 

        0 0 0 

    19200 

    NAGER/WTD 

    x Act, 1961.    

    Report: 20

    ut not due for pDeposit 

    0000

    000

    0000

      K. D)   Ankit P.Pa

    3,50,00

    0 0 0 0 

    19,200 

    3,69,20‐  

    Name

     

       Ke     

              

    015-16 18

    payment Unse

    Lo  

    0 0 0 0 

      0 0 0 

      0 0 0 0 

    atel  Ch

    00  3

    00 

    00  3‐  

    e of the DirectorKant

    ey Managerial P 

    8 | P a g e   

    ecured  oans 

    1,49,67,107 0 0 

    1,49,67,107 

    0 (12,03,735 ) 

    0  

    1,37,63,372  0  0 

    1,37,63,372 

    aitali P. Patel 

    ,50,000 

    0 0 0 0 

    19,200 0 

    ,69,200 

    rs tibhai J. Patel 

    0 0 

    19200 19200 

        0 0 0 

    19200 

    Personnel 

  • `   

        

       

    V

     APPCBPPCCPPC

    CS

    (c ) Profit2  Stock Op3  Sweat Eq4  Commiss

    as % of pothers, sp

    5  Others, pTotal 

    VII.    PENALTIES

    Ty

     A.  COMPANY Penalty Punishment Compounding B. DIRECTORS Penalty Punishment Compounding C. OTHER OFFICPenalty Punishment Compounding 

     ANNCHANGE IN PROSH.No

    1.   Kena H

    ts in lieu of salartion quity sion profit pecify please specify 

    S/ PUNISHMENT

    ype 

    ERS IN DEFAULT

    NEXURE‐B MOTERS' SHARName  

    Hardik Patel 

    ry under section

    T/ COMPPOUND

    Section ofCompanies

      

          

          

    T       

    EHOLDING ( SPEShare

    No.of Shareat the 

    beginning (01/04/2015

    9474

     17(3) of the Inc

    DING OF OFFENC

    f the s Act 

    BDesc

      

          

          

          

    ECIFY IF THERE Ieholding  

    5) 

    % of shares of the Company 

    44  3.12

    3

    come Tax Act, 19

    CES 

    rief ription 

    D

    Co

      

          

          

          

    S NO CHANGE)Date 

    28/04/15 30/04/15 05/05/15 06/05/15 08/05/15 14/05/15 15/05/15 03/06/15 04/06/15 05/06/15 08/06/15 09/06/15 10/06/15 12/06/15 10/07/15 20/07/15 31/07/15 06/08/15 07/08/15 25/08/15 27/08/15 28/08/15 31/08/15 01/09/15 02/09/15 

    30th Annual

    961          

    etails of PenaltyPunishment/ 

    ompounding feeimposed 

    Increase/Decse In 

    Shareholdin

    15 425 100 502 2533 4449 553 450 200 200 300 2200 2162 17 26 

    1500 2 

    19606 9849 552 599 200 352 3547 2604 

    Report: 20

                                            

    y/ 

    es Authori/NCLT /

      

          

          

          

    crea

    ng 

    Reason

    PurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchasePurchase

    015-16 19

    ty (RD /Court) 

    Appeany (

      

          

          

          

      CumuShareholdinyear (01/0

    31/03No.of Shares 

    e  94759 e  95184 e  95284 e  95786 e  98319 e  102768 e  103321 e  103771 e  103971 e  104171 e  104471 e  106671 e  108833 e  108850 e  108876 e  110376 e  110378 e  129984 e  139833 e  140385 e  140984 e  141184 e  141536 e  145083 e  147687 

    9 | P a g e   

    eall made if (give details) 

    ulative ng During tha 04/2015p to 3/2016) % Of total Shares OF the Company 

    3.12 3.13 3.13 3.15 3.23 3.38 3.39 3.41 3.42 3.43 3.44 3.51 3.57 3.58 3.58 3.63 3.63 4.27 4.59 4.62 4.64 4.64 4.65 4.77 4.86 

  • 30th Annual Report: 2015-16 20 | P a g e   

    03/09/15  800  Purchase  148487  4.88 10/09/15  101  Purchase  148588  4.89 11/09/15  2  Purchase  148590  4.89 15/09/15  561  Purchase  149151  4.90 16/09/15  850  Purchase  150001  4.93 21/09/15  1  Purchase  150002  4.93 

    2. Chaitali Ankitbhai Patel  8500  0.28  29/4/2015  1000  Purchase   9500  0.31  

    3.   Ankit P. Patel  0  ‐   09/10/15  201  Purchase  201  0.01             19/10/15  11  Purchase  212  0.01             20/10/15  1  Purchase  213  0.01             17/12/15  212  Purchase  425  0.014             21/12/15  943  Purchase  1368  0.04    22/12/15  200  Purchase  1568  0.05 

    31/12/15  402  Purchase  1970  0.06 10/02/16  27  Purchase  1997  0.07 

            21/03/16  3554  Purchase  5551  0.18  

    ANNEXURE C (IV) SHAREHOLDING PATTERN OF TOP 10 SHAREHOLDERS (other than Direcors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs) 

    Shareholding in the beginning of the year  Shareholding at the end of the year 

    Sr. No. 

    Name of the Shareholder  No. Of Shares held 

    % of Shareholding 

    Sr. No. 

    Name of the Shareholder  No. Of Shares held 

    % of Shareholding 

    1.  Babubhai Kashiram Patel  71500  2.35  1.  Amrav Babulal Dugar  143940  4.73 2.  Chandrakant Mohanbhai Patel  71500  2.35  2.  Chandrakant Mohanbhai Patel  71500  2.35 3.  Lataben Natvarlal Patel  71500  2.35  3.  Lataben Natvarlal Patel  71500  2.35 4.  Rakeshkumar Ramanlal Patel  66500  2.19  4.  Babubhai Kashiram Patel  71500  2.35 5.  Shardaben Baldevbhai Patel  60800  1.99  5.  Rakeshkumar Ramanlal Patel  66500  2.19 6.  Mithani Investments Pvt. Ltd  56908  1.87  6.  Babulal Dugar  64397  2.12 7.  JM Financial Services Limited  55608  1.83  7.  Shardaben Baldevbhai Patel  60800  1.99 8.  Bhaveshbhai Baldevbhai Patel  53800  1.77  8.  Mithani Investments Pvt. Ltd  56908  1.87 9.  Ramanbhai Joitaram Patel  52100  1.71  9.  Bhaveshbhai Baldevbhai Patel  53800  1.77 10.  Amrav Babulal Dugar  48000  1.58  10.  Ramanbhai Joitaram Patel  52100  1.71   Total  608216  20.00    Total   712945  23.44 

     

                    

     

    ANNEXURE‐D (v) Shareholding of Directors & KMP 

    SH.No. 

    Name   Shareholding   Date  Increase/Decrease In Shareholding 

    Reason  Cumulative Shareholding During tha year (01/04/2015 

    to 31/03/2016) 

    No.of Shares at the beginning (01/04/2015) 

    % of shares of the Company 

    No.of Shares 

    % Of total Shares OF the Company 

    1  Chaitali Ankitbhai Patel  8500  0.28  29/4/2015  1000   Purchase    9500  0.31  

     2   Ankit P. Patel  0  ‐   09/10/15  201  Purchase   201  0.01             19/10/15  11  Purchase   212  0.01             20/10/15  1  Purchase   213  0.01             17/12/15  212  Purchase   425  0.014             21/12/15  943  Purchase   1368  0.04    22/12/15  200  Purchase   1568  0.05 

    31/12/15  402  Purchase   1970  0.06 10/02/16  27  Purchase   1997  0.07 21/03/16  3554  Purchase   5551  0.18 

      

     

  • 30th Annual Report: 2015-16 21 | P a g e   

    MR‐3 Secretarial Audit Report  

    FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st March, 2016  

    [Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014] 

    To, The Members,  K Z LEASING AND FINANCE LIMITED (CIN: L65910GJ1986PLC008864)  

    I  have  conducted  the  secretarial  audit  of  the  compliance  of  applicable  statutory  provisions  and  the  adherence  to  good corporate  practices  by  K  Z  LEASING  AND  FINANCE  LIMITED  (CIN:  L65910GJ1986PLC008864)  (hereinafter  called  the Company). Secretarial Audit was conducted  in a manner  that provided me a  reasonable basis  for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.  

    Based  on my  verification  of  the  Company’s books,  papers,  minute  books,  forms  and returns  filed and other records maintained  by  the  Company  and  also  the  information  provided  by  the  Company,  its  officers,  agents  and  authorized representatives during the conduct of secretarial audit,  I hereby  report  that  in  my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2016 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board‐processes and compliance‐ mechanism  in place to the extent,  in the manner and subject to the reporting made hereinafter.  I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and  other  records maintained  by  the  Company  as  per  Annexure  A  for  the  financial  year  ended  on  31st March,  2016 according to the provisions of:  

    (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; (ii) Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (‘SCRA’) and the rules made there under; (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye‐laws framed thereunder;  (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and  the  rules and regulations made  thereunder  to  the extent of Foreign 

    Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (v) The  following Regulations  and Guidelines prescribed under  the  Securities  and Exchange Board of  India Act, 1992 

    (‘SEBI Act’):  

    a) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; b) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011   c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992; d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009; e) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) 

    Guidelines, 1999 and The Securities and Ex